-
TOPCON TECHNOLOGY LIMITED - Cirencester Road, Minchinhampton, Stroud, Gloucestershire, Grossbritannien
Firmenprofil
- Handelsregisternummer
- 08272223
- Firmenstatus
- EINGETRAGEN
- Land
- Grossbritannien
- Protokollierter Sitz
- Cirencester Road
- Minchinhampton
- Stroud
- Gloucestershire
- GL6 9BH
- United Kingdom Cirencester Road, Minchinhampton, Stroud, Gloucestershire, GL6 9BH, United Kingdom UK
Management
- Geschäftsführung
- HESTER, Brian Joseph
- STAITE, Neil Anthony
- THOMAS, Gareth David
- Prokuristen
- STAITE, Neil Anthony
Firmendetails
- Geschäftszweig
- ltd
- Gründungsdatum
- 29.10.2012
- Alter der Firma 2012-10-29 11 Jahre
- SIC/NACE
- 26511
Eigentumsverhältnisse
- Beneficial Owners
- -
- Topcon Corporation
Landes-Besonderheiten
- Zusätzliche Statusdetails
- active
- Ehemalige Namen
- DIGI-STAR ACQUISITIONS UK LIMITED
- Bilanzhinterlegung
- Fälligkeit: 2022-12-31
- Letzte Einreichung: 2021-03-31
- Jahresmeldung
- Fälligkeit: 2021-11-12
- Letzte Einreichung: 2020-10-29
-
TOPCON TECHNOLOGY LIMITED Firmenbeschreibung
- TOPCON TECHNOLOGY LIMITED ist eine in Grossbritannien als ltd registrierte Firma mit der Register-Nr. 08272223. Ihr derzeitiger Status ist "eingetragen". Die Firma wurde 29.10.2012 registriert. TOPCON TECHNOLOGY LIMITED hat Ihre Tätigkeit zuvor unter dem Namen DIGI-STAR ACQUISITIONS UK LIMITED ausgeführt. Das Unternehmen ist mit dem SIC/NACE Code "26511" registriert. Das Unternehmen hat 3 Geschäftsführer und 1 Prokuristen.Die Firma kann schriftlich über Cirencester Road erreicht werden.
Jetzt sichern TOPCON TECHNOLOGY LIMITED HandelsregisterauszugJahresabschlussListe der GesellschafterGesellschaftsvertragBeneficial Owners Check
Sie befinden sich hier: Topcon Technology Limited - Cirencester Road, Minchinhampton, Stroud, Gloucestershire, Grossbritannien
- 2012-10-29
- 0-2
- 3-5
- 6-20
- 21-50
- 51+
- Jahre
Haben Sie gewusst? kompany stellt Ihnen amtliche & offizielle Dokumente zu TOPCON TECHNOLOGY LIMITED aus Handelsregister und Firmenbuch im Original zur Verfügung. Das garantieren wir.
Handelsregisterauszug
Amtlicher Nachweis der Existenz des Unternehmens
Jahresabschluss
Finanzdaten zum letzten Berichtsjahr
Liste der Gesellschafter
Angaben zu den Eigentumsverhältnissen
Gesellschaftsvertrag
Gründungsdokumente
Beneficial Owners Check
Angaben über den wirtschaftlichen Eigentümer (Beneficial Owner)
Amtliche Dokumente
Amtliche Dokumente direkt vom offiziellen Handelsregister
keyboard_arrow_down 2021
-
confirmation-statement-with-no-updates (2021-01-04) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-full (2021-11-26) - AA
keyboard_arrow_right 2020
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2020-08-12) - TM01
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2020-08-12) - AP01
-
accounts-with-accounts-type-full (2020-11-04) - AA
-
cessation-of-a-person-with-significant-control (2020-12-18) - PSC07
-
notification-of-a-person-with-significant-control (2020-12-18) - PSC02
keyboard_arrow_right 2019
-
confirmation-statement-with-updates (2019-11-11) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-group (2019-10-17) - AA
-
change-person-director-company-with-change-date (2019-05-20) - CH01
keyboard_arrow_right 2018
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2018-01-30) - AP01
-
confirmation-statement-with-updates (2018-10-31) - CS01
-
change-to-a-person-with-significant-control (2018-10-31) - PSC05
-
accounts-with-accounts-type-group (2018-10-24) - AA
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2018-01-30) - AD01
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2018-01-30) - TM01
keyboard_arrow_right 2017
-
accounts-with-accounts-type-group (2017-01-07) - AA
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2017-11-08) - AP01
-
confirmation-statement-with-no-updates (2017-11-08) - CS01
-
resolution (2017-12-08) - RESOLUTIONS
-
accounts-with-accounts-type-group (2017-12-15) - AA
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2017-12-14) - AP01
keyboard_arrow_right 2016
-
appoint-person-secretary-company-with-name-date (2016-01-14) - AP03
-
confirmation-statement-with-updates (2016-11-14) - CS01
-
auditors-resignation-company (2016-08-04) - AUD
-
change-account-reference-date-company-current-extended (2016-01-25) - AA01
keyboard_arrow_right 2015
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2015-11-09) - AR01
-
accounts-with-accounts-type-group (2015-10-13) - AA
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2015-08-27) - AP01
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2015-08-27) - TM01
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2015-08-24) - TM01
-
mortgage-satisfy-charge-full (2015-04-22) - MR04
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2015-08-24) - AP01
-
termination-secretary-company-with-name-termination-date (2015-08-24) - TM02
keyboard_arrow_right 2014
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2014-11-07) - AR01
-
accounts-with-accounts-type-group (2014-08-12) - AA
keyboard_arrow_right 2013
-
appoint-person-director-company-with-name (2013-02-04) - AP01
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2013-11-25) - AR01
-
appoint-person-director-company-with-name (2013-11-22) - AP01
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address (2013-11-11) - AD01
-
termination-director-company-with-name (2013-11-11) - TM01
keyboard_arrow_right 2012
-
capital-allotment-shares (2012-11-22) - SH01
-
incorporation-company (2012-10-29) - NEWINC
-
legacy (2012-11-09) - MG01
-
certificate-change-of-name-company (2012-10-31) - CERTNM
-
change-account-reference-date-company-current-extended (2012-10-29) - AA01
-
resolution (2012-11-22) - RESOLUTIONS