-
ERGEA HEALTHCARE LEEDS AND BELFAST LIMITED - 67 Upper Berkeley Street, First Floor, London, W1H 7QX, Grossbritannien
Firmenprofil
- Handelsregisternummer
- 08266811
- Firmenstatus
- EINGETRAGEN
- Land
- Grossbritannien
- Protokollierter Sitz
- 67 Upper Berkeley Street
- First Floor
- London
- W1H 7QX 67 Upper Berkeley Street, First Floor, London, W1H 7QX UK
Management
- Geschäftsführung
- BRAYDA DI SOLETO, Gugliemo
- CORTI, Michele
Firmendetails
- Geschäftszweig
- ltd
- Gründungsdatum
- 24.10.2012
- Alter der Firma 2012-10-24 11 Jahre
- SIC/NACE
- 86101
Eigentumsverhältnisse
- Beneficial Owners
- Medipass Healthcare Ltd
Landes-Besonderheiten
- Zusätzliche Statusdetails
- active
- Ehemalige Namen
- MEDIPASS HEALTHCARE LEEDS & BELFAST LIMITED
- Bilanzhinterlegung
- Fälligkeit: 2023-09-30
- Letzte Einreichung: 2021-12-31
- Jahresmeldung
- Fälligkeit: 2023-11-07
- Letzte Einreichung: 2022-10-24
-
ERGEA HEALTHCARE LEEDS AND BELFAST LIMITED Firmenbeschreibung
- ERGEA HEALTHCARE LEEDS AND BELFAST LIMITED ist eine in Grossbritannien als ltd registrierte Firma mit der Register-Nr. 08266811. Ihr derzeitiger Status ist "eingetragen". Die Firma wurde 24.10.2012 registriert. ERGEA HEALTHCARE LEEDS AND BELFAST LIMITED hat Ihre Tätigkeit zuvor unter dem Namen MEDIPASS HEALTHCARE LEEDS & BELFAST LIMITED ausgeführt. Das Unternehmen ist mit dem SIC/NACE Code "86101" registriert. Das Unternehmen hat 2 Geschäftsführer Die Firma kann schriftlich über 67 Upper Berkeley Street erreicht werden.
Jetzt sichern ERGEA HEALTHCARE LEEDS AND BELFAST LIMITED HandelsregisterauszugJahresabschlussListe der GesellschafterGesellschaftsvertragBeneficial Owners Check
Sie befinden sich hier: Ergea Healthcare Leeds And Belfast Limited - 67 Upper Berkeley Street, First Floor, London, W1H 7QX, Grossbritannien
- 2012-10-24
- 0-2
- 3-5
- 6-20
- 21-50
- 51+
- Jahre
Haben Sie gewusst? kompany stellt Ihnen amtliche & offizielle Dokumente zu ERGEA HEALTHCARE LEEDS AND BELFAST LIMITED aus Handelsregister und Firmenbuch im Original zur Verfügung. Das garantieren wir.
Handelsregisterauszug
Amtlicher Nachweis der Existenz des Unternehmens
Jahresabschluss
Finanzdaten zum letzten Berichtsjahr
Liste der Gesellschafter
Angaben zu den Eigentumsverhältnissen
Gesellschaftsvertrag
Gründungsdokumente
Beneficial Owners Check
Angaben über den wirtschaftlichen Eigentümer (Beneficial Owner)
Amtliche Dokumente
Amtliche Dokumente direkt vom offiziellen Handelsregister
keyboard_arrow_down 2023
-
certificate-change-of-name-company (2023-03-01) - CERTNM
-
mortgage-create-with-deed-with-charge-number-charge-creation-date (2023-05-15) - MR01
-
resolution (2023-05-16) - RESOLUTIONS
-
memorandum-articles (2023-05-16) - MA
keyboard_arrow_right 2022
-
accounts-with-accounts-type-small (2022-07-27) - AA
-
gazette-notice-compulsory (2022-01-11) - GAZ1
-
confirmation-statement-with-no-updates (2022-01-10) - CS01
-
gazette-filings-brought-up-to-date (2022-01-12) - DISS40
-
confirmation-statement-with-no-updates (2022-10-27) - CS01
keyboard_arrow_right 2021
-
accounts-with-accounts-type-small (2021-10-11) - AA
-
accounts-with-accounts-type-small (2021-01-08) - AA
keyboard_arrow_right 2020
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2020-12-21) - AP01
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2020-12-10) - AP01
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2020-12-10) - TM01
-
confirmation-statement-with-no-updates (2020-12-10) - CS01
keyboard_arrow_right 2019
-
accounts-with-accounts-type-small (2019-10-04) - AA
-
confirmation-statement-with-no-updates (2019-10-24) - CS01
keyboard_arrow_right 2018
-
confirmation-statement-with-no-updates (2018-11-26) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-small (2018-10-04) - AA
keyboard_arrow_right 2017
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2017-01-11) - TM01
-
confirmation-statement-with-no-updates (2017-11-28) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-small (2017-04-07) - AA
keyboard_arrow_right 2016
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2016-03-16) - AA
-
confirmation-statement-with-updates (2016-11-07) - CS01
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2016-07-01) - TM01
keyboard_arrow_right 2015
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2015-04-13) - AA
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2015-11-02) - AD01
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2015-11-02) - AR01
keyboard_arrow_right 2014
-
capital-statement-capital-company-with-date-currency-figure (2014-04-07) - SH19
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2014-10-31) - AR01
-
legacy (2014-04-07) - SH20
-
legacy (2014-04-07) - CAP-SS
-
resolution (2014-04-07) - RESOLUTIONS
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2014-03-18) - AA
keyboard_arrow_right 2013
-
appoint-person-director-company-with-name (2013-02-15) - AP01
-
memorandum-articles (2013-02-27) - MEM/ARTS
-
resolution (2013-03-08) - RESOLUTIONS
-
change-account-reference-date-company-previous-shortened (2013-03-11) - AA01
-
capital-allotment-shares (2013-05-30) - SH01
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address (2013-06-18) - AD01
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2013-10-29) - AR01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2013-04-08) - AA
-
termination-director-company-with-name (2013-02-15) - TM01
keyboard_arrow_right 2012
-
appoint-person-director-company-with-name (2012-12-03) - AP01
-
incorporation-company (2012-10-24) - NEWINC