-
DW CLOTHING LIMITED - Hjs Recovery (Uk) Ltd, 12-14 Carlton Place, Southampton, SO15 2EA, Grossbritannien
Firmenprofil
- Handelsregisternummer
- 08259554
- Firmenstatus
- EINGETRAGEN
- Land
- Grossbritannien
- Protokollierter Sitz
- Hjs Recovery (Uk) Ltd
- 12-14 Carlton Place
- Southampton
- SO15 2EA Hjs Recovery (Uk) Ltd, 12-14 Carlton Place, Southampton, SO15 2EA UK
Management
- Geschäftsführung
- HATHIRAMANI, David Kishan
- WARWICK, Daniel Mark
- Prokuristen
- -
Firmendetails
- Geschäftszweig
- ltd
- Gründungsdatum
- 18.10.2012
- Alter der Firma 2012-10-18 11 Jahre
- SIC/NACE
- 47710
Eigentumsverhältnisse
- Beneficial Owners
- Dksg Bespoke Limited
Landes-Besonderheiten
- Zusätzliche Statusdetails
- liquidation
- Bilanzhinterlegung
- Fälligkeit: 2018-02-28
- Letzte Einreichung: 2016-05-31
- lezte Bilanzhinterlegung
- 2014-10-18
- Jahresmeldung
- Fälligkeit: 2018-06-14
- Letzte Einreichung: 2017-05-31
-
DW CLOTHING LIMITED Firmenbeschreibung
- DW CLOTHING LIMITED ist eine in Grossbritannien als ltd registrierte Firma mit der Register-Nr. 08259554. Ihr derzeitiger Status ist "eingetragen". Die Firma wurde 18.10.2012 registriert. Das Unternehmen ist mit dem SIC/NACE Code "47710" registriert. Das Unternehmen hat 2 Geschäftsführer Die jährliche Meldung erfolgte zuletzt am 18.10.2014.Die Firma kann schriftlich über Hjs Recovery (Uk) Ltd erreicht werden.
Jetzt sichern DW CLOTHING LIMITED HandelsregisterauszugJahresabschlussListe der GesellschafterGesellschaftsvertragBeneficial Owners Check
Sie befinden sich hier: Dw Clothing Limited - Hjs Recovery (Uk) Ltd, 12-14 Carlton Place, Southampton, SO15 2EA, Grossbritannien
- 2012-10-18
- 0-2
- 3-5
- 6-20
- 21-50
- 51+
- Jahre
Haben Sie gewusst? kompany stellt Ihnen amtliche & offizielle Dokumente zu DW CLOTHING LIMITED aus Handelsregister und Firmenbuch im Original zur Verfügung. Das garantieren wir.
Handelsregisterauszug
Amtlicher Nachweis der Existenz des Unternehmens
Jahresabschluss
Finanzdaten zum letzten Berichtsjahr
Liste der Gesellschafter
Angaben zu den Eigentumsverhältnissen
Gesellschaftsvertrag
Gründungsdokumente
Beneficial Owners Check
Angaben über den wirtschaftlichen Eigentümer (Beneficial Owner)
Amtliche Dokumente
Amtliche Dokumente direkt vom offiziellen Handelsregister
keyboard_arrow_down 2019
-
liquidation-voluntary-statement-of-receipts-and-payments-with-brought-down-date (2019-06-13) - LIQ03
keyboard_arrow_right 2018
-
liquidation-voluntary-statement-of-affairs (2018-03-23) - LIQ02
-
liquidation-voluntary-appointment-of-liquidator (2018-03-23) - 600
-
resolution (2018-03-23) - RESOLUTIONS
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2018-03-29) - AD01
-
mortgage-satisfy-charge-full (2018-06-16) - MR04
keyboard_arrow_right 2017
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2017-07-10) - AP01
-
confirmation-statement-with-updates (2017-07-07) - CS01
-
notification-of-a-person-with-significant-control (2017-07-07) - PSC02
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2017-02-24) - AA
keyboard_arrow_right 2016
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2016-02-24) - AD01
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2016-12-05) - AD01
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2016-07-07) - TM01
-
termination-secretary-company-with-name-termination-date (2016-07-07) - TM02
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2016-06-16) - AR01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2016-03-07) - AA
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2016-01-03) - TM01
keyboard_arrow_right 2015
-
mortgage-create-with-deed-with-charge-number-charge-creation-date (2015-10-30) - MR01
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2015-06-10) - AR01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2015-03-02) - AA
keyboard_arrow_right 2014
-
change-person-director-company-with-change-date (2014-12-05) - CH01
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2014-12-04) - AR01
-
change-person-director-company-with-change-date (2014-12-04) - CH01
-
capital-allotment-shares (2014-09-01) - SH01
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2014-07-28) - AR01
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2014-07-25) - AP01
keyboard_arrow_right 2013
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2013-10-23) - AR01
-
change-account-reference-date-company-previous-shortened (2013-06-20) - AA01
-
legacy (2013-02-21) - MG01
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address (2013-10-23) - AD01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2013-11-07) - AA
keyboard_arrow_right 2012
-
incorporation-company (2012-10-18) - NEWINC