-
SELLY PARK HEALTHCARE LIMITED - 12 Summer Hill Street, Birmingham, B1 2PE, England, Grossbritannien
Firmenprofil
- Handelsregisternummer
- 08258009
- Firmenstatus
- EINGETRAGEN
- Land
- Grossbritannien
- Protokollierter Sitz
- 12 Summer Hill Street
- Birmingham
- B1 2PE
- England 12 Summer Hill Street, Birmingham, B1 2PE, England UK
Management
- Geschäftsführung
- CHAUHAN, Charanpal Kaur
- SINGH, Dalbir
Firmendetails
- Geschäftszweig
- ltd
- Gründungsdatum
- 17.10.2012
- Alter der Firma 2012-10-17 11 Jahre
- SIC/NACE
- 87100
Eigentumsverhältnisse
- Beneficial Owners
- Mr Dalbir Singh
Landes-Besonderheiten
- Zusätzliche Statusdetails
- active
- Ehemalige Namen
- COMBERTON MANOR LIMITED
- Bilanzhinterlegung
- Fälligkeit: 2024-07-31
- Letzte Einreichung: 2022-10-31
- Jahresmeldung
- Fälligkeit: 2024-05-18
- Letzte Einreichung: 2023-05-04
-
SELLY PARK HEALTHCARE LIMITED Firmenbeschreibung
- SELLY PARK HEALTHCARE LIMITED ist eine in Grossbritannien als ltd registrierte Firma mit der Register-Nr. 08258009. Ihr derzeitiger Status ist "eingetragen". Die Firma wurde 17.10.2012 registriert. SELLY PARK HEALTHCARE LIMITED hat Ihre Tätigkeit zuvor unter dem Namen COMBERTON MANOR LIMITED ausgeführt. Das Unternehmen ist mit dem SIC/NACE Code "87100" registriert. Das Unternehmen hat 2 Geschäftsführer Die Bilanz wurde zuletzt am 31.10.2022 hinterlegt.Die Firma kann schriftlich über 12 Summer Hill Street erreicht werden.
Jetzt sichern SELLY PARK HEALTHCARE LIMITED HandelsregisterauszugJahresabschlussListe der GesellschafterGesellschaftsvertragBeneficial Owners Check
Sie befinden sich hier: Selly Park Healthcare Limited - 12 Summer Hill Street, Birmingham, B1 2PE, England, Grossbritannien
- 2012-10-17
- 0-2
- 3-5
- 6-20
- 21-50
- 51+
- Jahre
Haben Sie gewusst? kompany stellt Ihnen amtliche & offizielle Dokumente zu SELLY PARK HEALTHCARE LIMITED aus Handelsregister und Firmenbuch im Original zur Verfügung. Das garantieren wir.
Handelsregisterauszug
Amtlicher Nachweis der Existenz des Unternehmens
Jahresabschluss
Finanzdaten zum letzten Berichtsjahr
Liste der Gesellschafter
Angaben zu den Eigentumsverhältnissen
Gesellschaftsvertrag
Gründungsdokumente
Beneficial Owners Check
Angaben über den wirtschaftlichen Eigentümer (Beneficial Owner)
Amtliche Dokumente
Amtliche Dokumente direkt vom offiziellen Handelsregister
keyboard_arrow_down 2023
-
confirmation-statement-with-no-updates (2023-05-17) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2023-07-31) - AA
keyboard_arrow_right 2022
-
confirmation-statement-with-no-updates (2022-05-12) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2022-07-25) - AA
-
accounts-amended-with-accounts-type-total-exemption-full (2022-09-29) - AAMD
-
change-person-director-company-with-change-date (2022-10-07) - CH01
keyboard_arrow_right 2021
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2021-10-18) - AD01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2021-07-31) - AA
-
confirmation-statement-with-no-updates (2021-05-17) - CS01
keyboard_arrow_right 2020
-
confirmation-statement-with-no-updates (2020-05-12) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2020-09-06) - AA
keyboard_arrow_right 2019
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2019-07-31) - AA
-
accounts-amended-with-accounts-type-total-exemption-full (2019-06-14) - AAMD
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2019-05-29) - AD01
-
confirmation-statement-with-no-updates (2019-05-12) - CS01
-
change-person-director-company-with-change-date (2019-03-13) - CH01
-
notification-of-a-person-with-significant-control (2019-02-28) - PSC01
keyboard_arrow_right 2018
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2018-07-28) - AA
-
withdrawal-of-a-person-with-significant-control-statement (2018-05-03) - PSC09
-
capital-allotment-shares (2018-05-03) - SH01
-
capital-allotment-shares (2018-05-04) - SH01
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2018-04-03) - AD01
-
confirmation-statement-with-updates (2018-05-04) - CS01
keyboard_arrow_right 2017
-
confirmation-statement-with-no-updates (2017-12-11) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2017-07-31) - AA
keyboard_arrow_right 2016
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2016-04-19) - AD01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2016-07-30) - AA
-
confirmation-statement-with-updates (2016-10-13) - CS01
keyboard_arrow_right 2015
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2015-12-11) - AP01
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2015-12-11) - AR01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2015-07-31) - AA
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2015-02-04) - AR01
keyboard_arrow_right 2014
-
mortgage-create-with-deed-with-charge-number-charge-creation-date (2014-08-28) - MR01
-
accounts-with-accounts-type-dormant (2014-07-17) - AA
-
mortgage-create-with-deed-with-charge-number (2014-05-24) - MR01
-
mortgage-create-with-deed-with-charge-number (2014-04-17) - MR01
-
gazette-filings-brought-up-to-date (2014-02-19) - DISS40
-
certificate-change-of-name-company (2014-02-18) - CERTNM
-
gazette-notice-compulsary (2014-02-18) - GAZ1
-
termination-director-company-with-name (2014-02-17) - TM01
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2014-02-17) - AR01
keyboard_arrow_right 2012
-
incorporation-company (2012-10-17) - NEWINC