-
LOCA VENTURES LIMITED - Hollybush, Upper Bond Street, Hinckley, Leicestershire, Grossbritannien
Firmenprofil
- Handelsregisternummer
- 08215119
- Firmenstatus
- EINGETRAGEN
- Land
- Grossbritannien
- Protokollierter Sitz
- Hollybush
- Upper Bond Street
- Hinckley
- Leicestershire
- LE10 1RH Hollybush, Upper Bond Street, Hinckley, Leicestershire, LE10 1RH UK
Management
- Geschäftsführung
- FATEHMAHOMED, Mohamed Annes
Firmendetails
- Geschäftszweig
- ltd
- Gründungsdatum
- 14.09.2012
- Alter der Firma 2012-09-14 11 Jahre
- SIC/NACE
- 55100
Eigentumsverhältnisse
- Beneficial Owners
- -
- Sib Global Trading Inc
- Sib Global Trading Inc
Landes-Besonderheiten
- Zusätzliche Statusdetails
- Active
- Bilanzhinterlegung
- Fälligkeit: 2024-12-31
- Letzte Einreichung: 2023-03-31
- Jahresmeldung
- Fälligkeit: 2025-01-17
- Letzte Einreichung: 2024-01-03
-
LOCA VENTURES LIMITED Firmenbeschreibung
- LOCA VENTURES LIMITED ist eine in Grossbritannien als ltd registrierte Firma mit der Register-Nr. 08215119. Ihr derzeitiger Status ist "eingetragen". Die Firma wurde 14.09.2012 registriert. Das Unternehmen ist mit dem SIC/NACE Code "55100" registriert. Das Unternehmen hat 1 Geschäftsführer Die Firma kann schriftlich über Hollybush erreicht werden.
Jetzt sichern LOCA VENTURES LIMITED HandelsregisterauszugJahresabschlussListe der GesellschafterGesellschaftsvertragBeneficial Owners Check
Sie befinden sich hier: Loca Ventures Limited - Hollybush, Upper Bond Street, Hinckley, Leicestershire, Grossbritannien
- 2012-09-14
- 0-2
- 3-5
- 6-20
- 21-50
- 51+
- Jahre
Haben Sie gewusst? kompany stellt Ihnen amtliche & offizielle Dokumente zu LOCA VENTURES LIMITED aus Handelsregister und Firmenbuch im Original zur Verfügung. Das garantieren wir.
Handelsregisterauszug
Amtlicher Nachweis der Existenz des Unternehmens
Jahresabschluss
Finanzdaten zum letzten Berichtsjahr
Liste der Gesellschafter
Angaben zu den Eigentumsverhältnissen
Gesellschaftsvertrag
Gründungsdokumente
Beneficial Owners Check
Angaben über den wirtschaftlichen Eigentümer (Beneficial Owner)
Amtliche Dokumente
Amtliche Dokumente direkt vom offiziellen Handelsregister
keyboard_arrow_down 2024
-
confirmation-statement-with-no-updates (2024-01-24) - CS01
-
gazette-notice-compulsory (2024-05-28) - GAZ1
-
accounts-with-accounts-type-micro-entity (2024-05-31) - AA
-
gazette-filings-brought-up-to-date (2024-06-01) - DISS40
keyboard_arrow_right 2023
-
confirmation-statement-with-no-updates (2023-02-06) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-unaudited-abridged (2023-03-31) - AA
keyboard_arrow_right 2022
-
confirmation-statement-with-no-updates (2022-02-02) - CS01
keyboard_arrow_right 2021
-
mortgage-satisfy-charge-full (2021-03-22) - MR04
-
confirmation-statement-with-no-updates (2021-03-22) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2021-12-22) - AA
keyboard_arrow_right 2020
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2020-12-08) - AA
-
confirmation-statement-with-no-updates (2020-02-25) - CS01
-
notification-of-a-person-with-significant-control (2020-02-25) - PSC02
-
cessation-of-a-person-with-significant-control (2020-02-25) - PSC07
keyboard_arrow_right 2019
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2019-12-23) - AA
-
confirmation-statement-with-updates (2019-02-01) - CS01
keyboard_arrow_right 2018
-
gazette-notice-compulsory (2018-03-27) - GAZ1
-
accounts-with-accounts-type-micro-entity (2018-12-27) - AA
-
gazette-filings-brought-up-to-date (2018-03-28) - DISS40
-
confirmation-statement-with-no-updates (2018-03-23) - CS01
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2018-01-11) - AP01
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2018-01-11) - TM01
keyboard_arrow_right 2017
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2017-12-21) - AA
-
confirmation-statement-with-updates (2017-01-03) - CS01
keyboard_arrow_right 2016
-
gazette-filings-brought-up-to-date (2016-03-09) - DISS40
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2016-03-29) - AA
-
confirmation-statement-with-updates (2016-10-04) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2016-12-22) - AA
-
confirmation-statement-with-updates (2016-11-18) - CS01
-
gazette-notice-compulsory (2016-03-08) - GAZ1
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2016-11-10) - TM01
keyboard_arrow_right 2015
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2015-08-31) - AR01
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2015-06-23) - AP01
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2015-06-23) - TM01
-
change-account-reference-date-company-previous-extended (2015-06-18) - AA01
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2015-06-08) - AD01
keyboard_arrow_right 2014
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2014-10-03) - AR01
-
mortgage-create-with-deed-with-charge-number (2014-06-06) - MR01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2014-06-05) - AA
keyboard_arrow_right 2013
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2013-11-04) - AR01
-
termination-director-company-with-name (2013-07-24) - TM01
-
termination-director-company-with-name (2013-07-23) - TM01
keyboard_arrow_right 2012
-
termination-director-company-with-name (2012-11-27) - TM01
-
incorporation-company (2012-09-14) - NEWINC