-
SIMPILL LTD - Waterloo House, Thornton Street, Newcastle Upon Tyne, NE1 4AP, Grossbritannien
Firmenprofil
- Handelsregisternummer
- 08207278
- Firmenstatus
- EINGETRAGEN
- Land
- Grossbritannien
- Protokollierter Sitz
- Waterloo House
- Thornton Street
- Newcastle Upon Tyne
- NE1 4AP
- England Waterloo House, Thornton Street, Newcastle Upon Tyne, NE1 4AP, England UK
Management
- Geschäftsführung
- PILSBURY, Roger Graham
- PURI, Anoop
- Prokuristen
- STRUTT, Cheryl Marie
Firmendetails
- Geschäftszweig
- ltd
- Gründungsdatum
- 10.09.2012
- Alter der Firma 2012-09-10 11 Jahre
- SIC/NACE
- 47730
Eigentumsverhältnisse
- Beneficial Owners
- -
- Aspire Wellbeing Limited
- -
- -
- -
Landes-Besonderheiten
- Zusätzliche Statusdetails
- Active
- Ehemalige Namen
- PHARMACY 2000 LIMITED
- Bilanzhinterlegung
- Fälligkeit: 2015-05-31
- Letzte Einreichung: 2013-08-31
- Jahresmeldung
- Fälligkeit: 2024-06-07
- Letzte Einreichung: 2023-05-24
-
SIMPILL LTD Firmenbeschreibung
- SIMPILL LTD ist eine in Grossbritannien als ltd registrierte Firma mit der Register-Nr. 08207278. Ihr derzeitiger Status ist "eingetragen". Die Firma wurde 10.09.2012 registriert. SIMPILL LTD hat Ihre Tätigkeit zuvor unter dem Namen PHARMACY 2000 LIMITED ausgeführt. Das Unternehmen ist mit dem SIC/NACE Code "47730" registriert. Das Unternehmen hat 2 Geschäftsführer und 1 Prokuristen.Die Firma kann schriftlich über Waterloo House erreicht werden.
Jetzt sichern SIMPILL LTD HandelsregisterauszugJahresabschlussListe der GesellschafterGesellschaftsvertragBeneficial Owners Check
Sie befinden sich hier: Simpill Ltd - Waterloo House, Thornton Street, Newcastle Upon Tyne, NE1 4AP, Grossbritannien
- 2012-09-10
- 0-2
- 3-5
- 6-20
- 21-50
- 51+
- Jahre
Haben Sie gewusst? kompany stellt Ihnen amtliche & offizielle Dokumente zu SIMPILL LTD aus Handelsregister und Firmenbuch im Original zur Verfügung. Das garantieren wir.
Handelsregisterauszug
Amtlicher Nachweis der Existenz des Unternehmens
Jahresabschluss
Finanzdaten zum letzten Berichtsjahr
Liste der Gesellschafter
Angaben zu den Eigentumsverhältnissen
Gesellschaftsvertrag
Gründungsdokumente
Beneficial Owners Check
Angaben über den wirtschaftlichen Eigentümer (Beneficial Owner)
Amtliche Dokumente
Amtliche Dokumente direkt vom offiziellen Handelsregister
keyboard_arrow_down 2023
-
legacy (2023-07-27) - GUARANTEE2
-
accounts-with-accounts-type-audit-exemption-subsiduary (2023-08-10) - AA
-
legacy (2023-08-10) - AGREEMENT2
-
legacy (2023-08-10) - GUARANTEE2
-
confirmation-statement-with-no-updates (2023-06-16) - CS01
-
legacy (2023-07-11) - GUARANTEE2
-
legacy (2023-07-11) - AGREEMENT2
-
legacy (2023-08-10) - PARENT_ACC
keyboard_arrow_right 2022
-
accounts-with-accounts-type-small (2022-06-27) - AA
-
confirmation-statement-with-no-updates (2022-07-04) - CS01
keyboard_arrow_right 2021
-
cessation-of-a-person-with-significant-control (2021-02-15) - PSC07
-
accounts-with-accounts-type-small (2021-07-10) - AA
-
confirmation-statement-with-updates (2021-07-01) - CS01
-
change-to-a-person-with-significant-control (2021-02-15) - PSC05
keyboard_arrow_right 2020
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2020-04-06) - AD01
-
notification-of-a-person-with-significant-control (2020-01-09) - PSC02
-
cessation-of-a-person-with-significant-control (2020-01-09) - PSC07
-
confirmation-statement-with-updates (2020-08-11) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2020-10-02) - AA
keyboard_arrow_right 2019
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2019-06-28) - AA
-
notification-of-a-person-with-significant-control (2019-05-24) - PSC01
-
confirmation-statement-with-updates (2019-05-24) - CS01
-
cessation-of-a-person-with-significant-control (2019-05-24) - PSC07
keyboard_arrow_right 2018
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2018-06-28) - AA
-
cessation-of-a-person-with-significant-control (2018-09-13) - PSC07
-
notification-of-a-person-with-significant-control (2018-09-13) - PSC02
-
confirmation-statement-with-updates (2018-09-13) - CS01
-
change-to-a-person-with-significant-control (2018-09-13) - PSC05
-
resolution (2018-09-13) - RESOLUTIONS
keyboard_arrow_right 2017
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2017-05-24) - AA
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2017-06-16) - TM01
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2017-09-15) - TM01
-
appoint-person-secretary-company-with-name-date (2017-09-15) - AP03
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2017-09-15) - AP01
-
confirmation-statement-with-no-updates (2017-09-21) - CS01
-
change-account-reference-date-company-previous-extended (2017-10-03) - AA01
keyboard_arrow_right 2016
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2016-05-20) - AA
-
confirmation-statement-with-updates (2016-09-12) - CS01
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2016-09-12) - AP01
keyboard_arrow_right 2015
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2015-09-21) - AR01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2015-05-20) - AA
keyboard_arrow_right 2014
-
resolution (2014-11-18) - RESOLUTIONS
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2014-09-17) - AR01
-
accounts-with-accounts-type-dormant (2014-05-07) - AA
-
resolution (2014-02-19) - RESOLUTIONS
-
capital-allotment-shares (2014-02-19) - SH01
keyboard_arrow_right 2013
-
change-sail-address-company (2013-09-26) - AD02
-
move-registers-to-sail-company (2013-09-26) - AD03
-
appoint-person-director-company-with-name (2013-09-26) - AP01
-
change-account-reference-date-company-previous-shortened (2013-09-26) - AA01
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address (2013-09-26) - AD01
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2013-09-26) - AR01
keyboard_arrow_right 2012
-
incorporation-company (2012-09-10) - NEWINC