-
DRIBUILD GROUP LIMITED - 14 Queen Square, Bath, BA1 2HN, Grossbritannien
Firmenprofil
- Handelsregisternummer
- 08193412
- Firmenstatus
- EINGETRAGEN
- Land
- Grossbritannien
- Protokollierter Sitz
- 14 Queen Square
- Bath
- BA1 2HN 14 Queen Square, Bath, BA1 2HN UK
Management
- Geschäftsführung
- MARSHMAN, Adrian Jeremy Stuart
- TYLER, Matthew Douglas
Firmendetails
- Geschäftszweig
- ltd
- Gründungsdatum
- 29.08.2012
- Alter der Firma 2012-08-29 11 Jahre
- SIC/NACE
- 64203
Eigentumsverhältnisse
- Beneficial Owners
- -
- Mr Dave Kipling
- Mr Michael Holt
- Bmn Dribuild Ltd
- -
- -
Landes-Besonderheiten
- Zusätzliche Statusdetails
- liquidation
- Ehemalige Namen
- DRIBUILD HOLDINGS LIMITED
- Bilanzhinterlegung
- Fälligkeit: 2020-01-31
- Letzte Einreichung: 2018-04-30
- Jahresmeldung
- Fälligkeit: 2019-11-22
- Letzte Einreichung: 2018-11-08
-
DRIBUILD GROUP LIMITED Firmenbeschreibung
- DRIBUILD GROUP LIMITED ist eine in Grossbritannien als ltd registrierte Firma mit der Register-Nr. 08193412. Ihr derzeitiger Status ist "eingetragen". Die Firma wurde 29.08.2012 registriert. DRIBUILD GROUP LIMITED hat Ihre Tätigkeit zuvor unter dem Namen DRIBUILD HOLDINGS LIMITED ausgeführt. Das Unternehmen ist mit dem SIC/NACE Code "64203" registriert. Das Unternehmen hat 2 Geschäftsführer Die Firma kann schriftlich über 14 Queen Square erreicht werden.
Jetzt sichern DRIBUILD GROUP LIMITED HandelsregisterauszugJahresabschlussListe der GesellschafterGesellschaftsvertragBeneficial Owners Check
Sie befinden sich hier: Dribuild Group Limited - 14 Queen Square, Bath, BA1 2HN, Grossbritannien
- 2012-08-29
- 0-2
- 3-5
- 6-20
- 21-50
- 51+
- Jahre
Haben Sie gewusst? kompany stellt Ihnen amtliche & offizielle Dokumente zu DRIBUILD GROUP LIMITED aus Handelsregister und Firmenbuch im Original zur Verfügung. Das garantieren wir.
Handelsregisterauszug
Amtlicher Nachweis der Existenz des Unternehmens
Jahresabschluss
Finanzdaten zum letzten Berichtsjahr
Liste der Gesellschafter
Angaben zu den Eigentumsverhältnissen
Gesellschaftsvertrag
Gründungsdokumente
Beneficial Owners Check
Angaben über den wirtschaftlichen Eigentümer (Beneficial Owner)
Amtliche Dokumente
Amtliche Dokumente direkt vom offiziellen Handelsregister
keyboard_arrow_down 2021
-
liquidation-voluntary-statement-of-receipts-and-payments-with-brought-down-date (2021-03-03) - LIQ03
keyboard_arrow_right 2020
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2020-02-21) - AD01
-
liquidation-voluntary-appointment-of-liquidator (2020-02-20) - 600
-
resolution (2020-02-20) - RESOLUTIONS
-
liquidation-voluntary-statement-of-affairs (2020-02-20) - LIQ02
keyboard_arrow_right 2019
-
notice-of-removal-of-a-director (2019-10-02) - AP01
-
notification-of-a-person-with-significant-control (2019-10-02) - PSC02
-
cessation-of-a-person-with-significant-control (2019-10-02) - PSC07
-
mortgage-create-with-deed-with-charge-number-charge-creation-date (2019-09-12) - MR01
-
mortgage-create-with-deed-with-charge-number-charge-creation-date (2019-09-05) - MR01
-
resolution (2019-07-30) - RESOLUTIONS
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2019-07-03) - TM01
-
accounts-with-accounts-type-group (2019-01-04) - AA
-
(2019-10-02) - ANNOTATION
keyboard_arrow_right 2018
-
change-to-a-person-with-significant-control (2018-10-16) - PSC04
-
legacy (2018-11-14) - RP04CS01
-
confirmation-statement-with-updates (2018-11-13) - CS01
-
change-person-director-company-with-change-date (2018-10-19) - CH01
-
change-person-director-company-with-change-date (2018-10-16) - CH01
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2018-05-02) - AP01
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2018-05-02) - AD01
-
accounts-with-accounts-type-group (2018-01-05) - AA
keyboard_arrow_right 2017
-
confirmation-statement-with-no-updates (2017-11-08) - CS01
keyboard_arrow_right 2016
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2016-01-06) - AP01
-
accounts-with-accounts-type-group (2016-10-21) - AA
-
capital-allotment-shares (2016-01-13) - SH01
-
resolution (2016-01-13) - RESOLUTIONS
-
capital-allotment-shares (2016-03-17) - SH01
-
resolution (2016-08-04) - RESOLUTIONS
-
confirmation-statement-with-updates (2016-11-08) - CS01
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2016-09-08) - TM01
-
confirmation-statement-with-updates (2016-10-06) - CS01
-
mortgage-create-with-deed-with-charge-number-charge-creation-date (2016-10-10) - MR01
keyboard_arrow_right 2015
-
accounts-with-accounts-type-group (2015-11-12) - AA
-
capital-alter-shares-subdivision (2015-06-12) - SH02
-
capital-cancellation-shares (2015-10-15) - SH06
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2015-09-29) - AR01
-
resolution (2015-10-15) - RESOLUTIONS
-
capital-return-purchase-own-shares (2015-10-15) - SH03
keyboard_arrow_right 2014
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2014-10-14) - AR01
-
accounts-with-accounts-type-dormant (2014-01-10) - AA
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2014-08-12) - AA
keyboard_arrow_right 2013
-
change-account-reference-date-company-previous-shortened (2013-12-05) - AA01
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2013-09-12) - AR01
-
termination-director-company-with-name (2013-02-01) - TM01
keyboard_arrow_right 2012
-
change-sail-address-company (2012-11-19) - AD02
-
capital-allotment-shares (2012-09-24) - SH01
-
incorporation-company (2012-08-29) - NEWINC