-
M S PLANNING LTD - Advantage Accountancy & Advisory Ltd Second Floor, Avalon House, 5-7 Cathedral Road, Cardiff, CF11 9HA, Grossbritannien
Firmenprofil
- Handelsregisternummer
- 08184236
- Firmenstatus
- EINGETRAGEN
- Land
- Grossbritannien
- Protokollierter Sitz
- Advantage Accountancy & Advisory Ltd Second Floor, Avalon House
- 5-7 Cathedral Road
- Cardiff
- CF11 9HA
- United Kingdom Advantage Accountancy & Advisory Ltd Second Floor, Avalon House, 5-7 Cathedral Road, Cardiff, CF11 9HA, United Kingdom UK
Management
- Geschäftsführung
- HISLOP, Mark
- HISLOP, Cerys
Firmendetails
- Geschäftszweig
- ltd
- Gründungsdatum
- 17.08.2012
- Alter der Firma 2012-08-17 11 Jahre
- SIC/NACE
- 69203
Eigentumsverhältnisse
- Beneficial Owners
- Mr Mark Hislop
Landes-Besonderheiten
- Zusätzliche Statusdetails
- Active
- Bilanzhinterlegung
- Fälligkeit: 2024-12-31
- Letzte Einreichung: 2023-03-31
- Jahresmeldung
- Fälligkeit: 2024-08-31
- Letzte Einreichung: 2023-08-17
-
M S PLANNING LTD Firmenbeschreibung
- M S PLANNING LTD ist eine in Grossbritannien als ltd registrierte Firma mit der Register-Nr. 08184236. Ihr derzeitiger Status ist "eingetragen". Die Firma wurde 17.08.2012 registriert. Das Unternehmen ist mit dem SIC/NACE Code "69203" registriert. Das Unternehmen hat 2 Geschäftsführer Die Firma kann schriftlich über Advantage Accountancy & Advisory Ltd Second Floor, Avalon House erreicht werden.
Jetzt sichern M S PLANNING LTD HandelsregisterauszugJahresabschlussListe der GesellschafterGesellschaftsvertragBeneficial Owners Check
Sie befinden sich hier: M S Planning Ltd - Advantage Accountancy & Advisory Ltd Second Floor, Avalon House, 5-7 Cathedral Road, Cardiff, CF11 9HA, Grossbritannien
- 2012-08-17
- 0-2
- 3-5
- 6-20
- 21-50
- 51+
- Jahre
Haben Sie gewusst? kompany stellt Ihnen amtliche & offizielle Dokumente zu M S PLANNING LTD aus Handelsregister und Firmenbuch im Original zur Verfügung. Das garantieren wir.
Handelsregisterauszug
Amtlicher Nachweis der Existenz des Unternehmens
Jahresabschluss
Finanzdaten zum letzten Berichtsjahr
Liste der Gesellschafter
Angaben zu den Eigentumsverhältnissen
Gesellschaftsvertrag
Gründungsdokumente
Beneficial Owners Check
Angaben über den wirtschaftlichen Eigentümer (Beneficial Owner)
Amtliche Dokumente
Amtliche Dokumente direkt vom offiziellen Handelsregister
keyboard_arrow_down 2023
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2023-11-06) - AA
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2023-01-09) - AP01
-
change-person-director-company-with-change-date (2023-07-12) - CH01
-
confirmation-statement-with-no-updates (2023-08-17) - CS01
keyboard_arrow_right 2022
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2022-01-21) - AD01
-
confirmation-statement-with-no-updates (2022-08-17) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2022-12-12) - AA
keyboard_arrow_right 2021
-
confirmation-statement-with-no-updates (2021-08-17) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2021-12-14) - AA
keyboard_arrow_right 2020
-
confirmation-statement-with-no-updates (2020-08-17) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2020-12-18) - AA
keyboard_arrow_right 2019
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2019-12-20) - AA
-
confirmation-statement-with-no-updates (2019-08-21) - CS01
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2019-04-16) - AD01
keyboard_arrow_right 2018
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2018-11-08) - AA
-
confirmation-statement-with-updates (2018-08-21) - CS01
keyboard_arrow_right 2017
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2017-12-18) - AA
-
confirmation-statement-with-updates (2017-08-17) - CS01
-
notification-of-a-person-with-significant-control (2017-07-17) - PSC01
-
withdrawal-of-a-person-with-significant-control-statement (2017-07-17) - PSC09
keyboard_arrow_right 2016
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2016-11-14) - AA
-
confirmation-statement-with-updates (2016-08-31) - CS01
keyboard_arrow_right 2015
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2015-05-22) - TM01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2015-01-08) - AA
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2015-05-08) - AA
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2015-09-01) - AR01
keyboard_arrow_right 2014
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2014-08-13) - AD01
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2014-09-05) - AR01
-
change-person-director-company-with-change-date (2014-09-05) - CH01
keyboard_arrow_right 2013
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2013-10-05) - AR01
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2013-10-05) - AP01
-
capital-name-of-class-of-shares (2013-07-22) - SH08
-
capital-variation-of-rights-attached-to-shares (2013-07-22) - SH10
-
capital-allotment-shares (2013-07-22) - SH01
-
resolution (2013-07-22) - RESOLUTIONS
-
accounts-with-made-up-date (2013-06-12) - AA
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2013-06-12) - TM01
-
change-account-reference-date-company-previous-shortened (2013-06-12) - AA01
keyboard_arrow_right 2012
-
incorporation-company (2012-08-17) - NEWINC