-
WORKPLACE PROPERTIES LTD - Montpellier House, Montpellier Drive, Cheltenham, Gloucestershire, Grossbritannien
Firmenprofil
- Handelsregisternummer
- 08176431
- Firmenstatus
- EINGETRAGEN
- Land
- Grossbritannien
- Protokollierter Sitz
- Montpellier House
- Montpellier Drive
- Cheltenham
- Gloucestershire
- GL50 1TY Montpellier House, Montpellier Drive, Cheltenham, Gloucestershire, GL50 1TY UK
Management
- Geschäftsführung
- COSTELLOE, Rosalind June
Firmendetails
- Geschäftszweig
- ltd
- Gründungsdatum
- 13.08.2012
- Alter der Firma 2012-08-13 11 Jahre
- SIC/NACE
- 68320
Eigentumsverhältnisse
- Beneficial Owners
- Mr Richard William Costelloe
- Mrs Shelley Preston-Oversby
- -
Landes-Besonderheiten
- Zusätzliche Statusdetails
- liquidation
- Ehemalige Namen
- ALBEIT PROPERTIES LIMITED
- Bilanzhinterlegung
- Fälligkeit: 2020-03-29
- Letzte Einreichung: 2017-12-31
- Jahresmeldung
- Fälligkeit: 2021-08-27
- Letzte Einreichung: 2020-08-13
-
WORKPLACE PROPERTIES LTD Firmenbeschreibung
- WORKPLACE PROPERTIES LTD ist eine in Grossbritannien als ltd registrierte Firma mit der Register-Nr. 08176431. Ihr derzeitiger Status ist "eingetragen". Die Firma wurde 13.08.2012 registriert. WORKPLACE PROPERTIES LTD hat Ihre Tätigkeit zuvor unter dem Namen ALBEIT PROPERTIES LIMITED ausgeführt. Das Unternehmen ist mit dem SIC/NACE Code "68320" registriert. Das Unternehmen hat 1 Geschäftsführer Die Firma kann schriftlich über Montpellier House erreicht werden.
Jetzt sichern WORKPLACE PROPERTIES LTD HandelsregisterauszugJahresabschlussListe der GesellschafterGesellschaftsvertragBeneficial Owners Check
Sie befinden sich hier: Workplace Properties Ltd - Montpellier House, Montpellier Drive, Cheltenham, Gloucestershire, Grossbritannien
- 2012-08-13
- 0-2
- 3-5
- 6-20
- 21-50
- 51+
- Jahre
Haben Sie gewusst? kompany stellt Ihnen amtliche & offizielle Dokumente zu WORKPLACE PROPERTIES LTD aus Handelsregister und Firmenbuch im Original zur Verfügung. Das garantieren wir.
Handelsregisterauszug
Amtlicher Nachweis der Existenz des Unternehmens
Jahresabschluss
Finanzdaten zum letzten Berichtsjahr
Liste der Gesellschafter
Angaben zu den Eigentumsverhältnissen
Gesellschaftsvertrag
Gründungsdokumente
Beneficial Owners Check
Angaben über den wirtschaftlichen Eigentümer (Beneficial Owner)
Amtliche Dokumente
Amtliche Dokumente direkt vom offiziellen Handelsregister
keyboard_arrow_down 2021
-
liquidation-compulsory-appointment-liquidator (2021-08-14) - WU04
-
liquidation-compulsory-winding-up-order (2021-08-02) - COCOMP
-
liquidation-compulsory-winding-up-order (2021-08-04) - COCOMP
-
dissolved-compulsory-strike-off-suspended (2021-01-06) - DISS16(SOAS)
keyboard_arrow_right 2020
-
cessation-of-a-person-with-significant-control (2020-10-09) - PSC07
-
change-to-a-person-with-significant-control (2020-10-09) - PSC04
-
confirmation-statement-with-updates (2020-10-09) - CS01
-
gazette-notice-compulsory (2020-12-22) - GAZ1
keyboard_arrow_right 2019
-
change-account-reference-date-company-current-shortened (2019-12-30) - AA01
-
mortgage-satisfy-charge-full (2019-10-12) - MR04
-
change-account-reference-date-company-previous-shortened (2019-10-01) - AA01
-
confirmation-statement-with-no-updates (2019-08-21) - CS01
keyboard_arrow_right 2018
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2018-11-29) - AA
-
gazette-filings-brought-up-to-date (2018-10-31) - DISS40
-
gazette-notice-compulsory (2018-10-30) - GAZ1
-
confirmation-statement-with-no-updates (2018-10-29) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2018-01-24) - AA
-
gazette-filings-brought-up-to-date (2018-01-17) - DISS40
-
confirmation-statement-with-no-updates (2018-01-16) - CS01
keyboard_arrow_right 2017
-
change-account-reference-date-company-previous-extended (2017-02-16) - AA01
-
dissolved-compulsory-strike-off-suspended (2017-11-07) - DISS16(SOAS)
-
gazette-notice-compulsory (2017-11-07) - GAZ1
keyboard_arrow_right 2016
-
confirmation-statement-with-updates (2016-08-26) - CS01
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2016-08-25) - TM01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2016-08-16) - AA
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2016-08-14) - TM01
-
gazette-filings-brought-up-to-date (2016-08-13) - DISS40
-
gazette-notice-compulsory (2016-08-09) - GAZ1
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2016-08-01) - AP01
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2016-08-25) - AP01
keyboard_arrow_right 2015
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2015-08-03) - AA
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2015-09-25) - AR01
-
mortgage-create-with-deed-with-charge-number-charge-creation-date (2015-03-03) - MR01
keyboard_arrow_right 2014
-
change-person-director-company-with-change-date (2014-08-29) - CH01
-
mortgage-create-with-deed-with-charge-number (2014-08-20) - MR01
-
certificate-change-of-name-company (2014-08-07) - CERTNM
-
accounts-with-accounts-type-dormant (2014-05-22) - AA
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2014-08-29) - AR01
-
certificate-change-of-name-company (2014-08-11) - CERTNM
keyboard_arrow_right 2013
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2013-09-04) - AR01
keyboard_arrow_right 2012
-
incorporation-company (2012-08-13) - NEWINC