-
TRK SHOREDITCH LIMITED - Ampney House Falcon Close, Quedgeley, Gloucester, GL2 4LS, Grossbritannien
Firmenprofil
- Handelsregisternummer
- 08167233
- Firmenstatus
- EINGETRAGEN
- Land
- Grossbritannien
- Protokollierter Sitz
- Ampney House Falcon Close
- Quedgeley
- Gloucester
- GL2 4LS
- United Kingdom Ampney House Falcon Close, Quedgeley, Gloucester, GL2 4LS, United Kingdom UK
Management
- Geschäftsführung
- PARNHAM, Michael Kevin
Firmendetails
- Geschäftszweig
- ltd
- Gründungsdatum
- 03.08.2012
- Alter der Firma 2012-08-03 12 Jahre
- SIC/NACE
- 56101
Eigentumsverhältnisse
- Beneficial Owners
- The Rum Kitchen Holdings Limited
Landes-Besonderheiten
- Zusätzliche Statusdetails
- active
- Ehemalige Namen
- ICARUS LEISURE NOTTING HILL LIMITED
- Bilanzhinterlegung
- Fälligkeit: 2022-04-30
- Letzte Einreichung: 2020-08-02
- Jahresmeldung
- Fälligkeit: 2021-08-17
- Letzte Einreichung: 2020-08-03
-
TRK SHOREDITCH LIMITED Firmenbeschreibung
- TRK SHOREDITCH LIMITED ist eine in Grossbritannien als ltd registrierte Firma mit der Register-Nr. 08167233. Ihr derzeitiger Status ist "eingetragen". Die Firma wurde 03.08.2012 registriert. TRK SHOREDITCH LIMITED hat Ihre Tätigkeit zuvor unter dem Namen ICARUS LEISURE NOTTING HILL LIMITED ausgeführt. Das Unternehmen ist mit dem SIC/NACE Code "56101" registriert. Das Unternehmen hat 1 Geschäftsführer Die Firma kann schriftlich über Ampney House Falcon Close erreicht werden.
Jetzt sichern TRK SHOREDITCH LIMITED HandelsregisterauszugJahresabschlussListe der GesellschafterGesellschaftsvertragBeneficial Owners Check
Sie befinden sich hier: Trk Shoreditch Limited - Ampney House Falcon Close, Quedgeley, Gloucester, GL2 4LS, Grossbritannien
- 2012-08-03
- 0-2
- 3-5
- 6-20
- 21-50
- 51+
- Jahre
Haben Sie gewusst? kompany stellt Ihnen amtliche & offizielle Dokumente zu TRK SHOREDITCH LIMITED aus Handelsregister und Firmenbuch im Original zur Verfügung. Das garantieren wir.
Handelsregisterauszug
Amtlicher Nachweis der Existenz des Unternehmens
Jahresabschluss
Finanzdaten zum letzten Berichtsjahr
Liste der Gesellschafter
Angaben zu den Eigentumsverhältnissen
Gesellschaftsvertrag
Gründungsdokumente
Beneficial Owners Check
Angaben über den wirtschaftlichen Eigentümer (Beneficial Owner)
Amtliche Dokumente
Amtliche Dokumente direkt vom offiziellen Handelsregister
keyboard_arrow_down 2021
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2021-04-23) - AA
keyboard_arrow_right 2020
-
resolution (2020-02-05) - RESOLUTIONS
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2020-04-30) - AA
-
confirmation-statement-with-updates (2020-08-19) - CS01
-
memorandum-articles (2020-10-16) - MA
-
resolution (2020-10-16) - RESOLUTIONS
-
mortgage-create-with-deed-with-charge-number-charge-creation-date (2020-10-13) - MR01
keyboard_arrow_right 2019
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2019-06-19) - AD01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2019-07-31) - AA
-
confirmation-statement-with-no-updates (2019-08-21) - CS01
-
change-to-a-person-with-significant-control (2019-03-20) - PSC05
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2019-11-19) - TM01
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2019-11-19) - AP01
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2019-09-18) - AD01
-
change-person-director-company-with-change-date (2019-06-25) - CH01
keyboard_arrow_right 2018
-
confirmation-statement-with-no-updates (2018-08-17) - CS01
-
gazette-filings-brought-up-to-date (2018-07-31) - DISS40
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2018-07-30) - AA
-
dissolved-compulsory-strike-off-suspended (2018-07-07) - DISS16(SOAS)
-
gazette-notice-compulsory (2018-07-03) - GAZ1
-
change-person-director-company-with-change-date (2018-02-19) - CH01
keyboard_arrow_right 2017
-
withdrawal-of-a-person-with-significant-control-statement (2017-08-11) - PSC09
-
confirmation-statement-with-no-updates (2017-08-11) - CS01
-
notification-of-a-person-with-significant-control (2017-08-11) - PSC02
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2017-05-31) - AA
keyboard_arrow_right 2016
-
confirmation-statement-with-updates (2016-08-03) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2016-05-07) - AA
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2016-03-02) - TM01
-
change-person-director-company-with-change-date (2016-08-17) - CH01
keyboard_arrow_right 2015
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2015-10-09) - AR01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2015-05-12) - AA
keyboard_arrow_right 2014
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2014-03-26) - AA
-
appoint-person-director-company-with-name (2014-06-17) - AP01
-
resolution (2014-06-18) - RESOLUTIONS
-
change-person-director-company-with-change-date (2014-10-21) - CH01
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2014-07-23) - AD01
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2014-10-28) - AR01
keyboard_arrow_right 2013
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2013-10-10) - AR01
-
change-account-reference-date-company-previous-shortened (2013-08-05) - AA01
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address (2013-03-08) - AD01
-
capital-allotment-shares (2013-02-06) - SH01
-
capital-alter-shares-subdivision (2013-01-05) - SH02
-
resolution (2013-01-05) - RESOLUTIONS
keyboard_arrow_right 2012
-
incorporation-company (2012-08-03) - NEWINC