-
COMPLETE CORPORATE FINANCE LIMITED - Fleming Court Leigh Road, Eastleigh, Southampton, Hampshire, Grossbritannien
Firmenprofil
- Handelsregisternummer
- 08152419
- Firmenstatus
- EINGETRAGEN
- Land
- Grossbritannien
- Protokollierter Sitz
- Fleming Court Leigh Road
- Eastleigh
- Southampton
- Hampshire
- SO50 9PD
- England Fleming Court Leigh Road, Eastleigh, Southampton, Hampshire, SO50 9PD, England UK
Management
- Geschäftsführung
- COGAN, Zachary Lee
- HARA, Ian Malcolm
- LLOYD, Joseph Patrick
Firmendetails
- Geschäftszweig
- ltd
- Gründungsdatum
- 23.07.2012
- Alter der Firma 2012-07-23 11 Jahre
- SIC/NACE
- 64910
Eigentumsverhältnisse
- Beneficial Owners
- -
- Cahp Holdings Limited
Landes-Besonderheiten
- Zusätzliche Statusdetails
- active
- Bilanzhinterlegung
- Fälligkeit: 2021-09-30
- Letzte Einreichung: 2019-12-31
- Jahresmeldung
- Fälligkeit: 2022-03-29
- Letzte Einreichung: 2021-03-15
-
COMPLETE CORPORATE FINANCE LIMITED Firmenbeschreibung
- COMPLETE CORPORATE FINANCE LIMITED ist eine in Grossbritannien als ltd registrierte Firma mit der Register-Nr. 08152419. Ihr derzeitiger Status ist "eingetragen". Die Firma wurde 23.07.2012 registriert. Das Unternehmen ist mit dem SIC/NACE Code "64910" registriert. Das Unternehmen hat 3 Geschäftsführer Die Firma kann schriftlich über Fleming Court Leigh Road erreicht werden.
Jetzt sichern COMPLETE CORPORATE FINANCE LIMITED HandelsregisterauszugJahresabschlussListe der GesellschafterGesellschaftsvertragBeneficial Owners Check
Sie befinden sich hier: Complete Corporate Finance Limited - Fleming Court Leigh Road, Eastleigh, Southampton, Hampshire, Grossbritannien
- 2012-07-23
- 0-2
- 3-5
- 6-20
- 21-50
- 51+
- Jahre
Haben Sie gewusst? kompany stellt Ihnen amtliche & offizielle Dokumente zu COMPLETE CORPORATE FINANCE LIMITED aus Handelsregister und Firmenbuch im Original zur Verfügung. Das garantieren wir.
Handelsregisterauszug
Amtlicher Nachweis der Existenz des Unternehmens
Jahresabschluss
Finanzdaten zum letzten Berichtsjahr
Liste der Gesellschafter
Angaben zu den Eigentumsverhältnissen
Gesellschaftsvertrag
Gründungsdokumente
Beneficial Owners Check
Angaben über den wirtschaftlichen Eigentümer (Beneficial Owner)
Amtliche Dokumente
Amtliche Dokumente direkt vom offiziellen Handelsregister
keyboard_arrow_down 2021
-
change-to-a-person-with-significant-control (2021-04-05) - PSC05
-
confirmation-statement-with-no-updates (2021-03-24) - CS01
keyboard_arrow_right 2020
-
confirmation-statement-with-no-updates (2020-03-30) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2020-11-09) - AA
keyboard_arrow_right 2019
-
change-to-a-person-with-significant-control (2019-12-17) - PSC05
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2019-12-17) - AD01
-
change-person-director-company-with-change-date (2019-12-17) - CH01
-
confirmation-statement-with-updates (2019-03-26) - CS01
-
cessation-of-a-person-with-significant-control (2019-03-26) - PSC07
-
notification-of-a-person-with-significant-control (2019-03-26) - PSC02
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2019-09-30) - AA
keyboard_arrow_right 2018
-
withdrawal-of-a-person-with-significant-control-statement (2018-03-28) - PSC09
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2018-09-14) - AA
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2018-05-16) - TM01
-
confirmation-statement-with-updates (2018-03-28) - CS01
-
notification-of-a-person-with-significant-control (2018-03-28) - PSC01
keyboard_arrow_right 2017
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2017-09-27) - AA
-
confirmation-statement-with-updates (2017-03-27) - CS01
keyboard_arrow_right 2016
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2016-09-28) - AA
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2016-05-26) - AR01
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2016-04-20) - AP01
keyboard_arrow_right 2015
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2015-09-17) - AA
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2015-09-01) - TM01
-
change-person-director-company-with-change-date (2015-04-09) - CH01
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2015-04-01) - AR01
keyboard_arrow_right 2014
-
change-account-reference-date-company-previous-extended (2014-02-17) - AA01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2014-04-22) - AA
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address (2014-05-28) - AD01
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2014-08-14) - AR01
-
change-person-director-company-with-change-date (2014-05-30) - CH01
-
mortgage-create-with-deed-with-charge-number-charge-creation-date (2014-10-22) - MR01
keyboard_arrow_right 2013
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2013-07-29) - AR01
keyboard_arrow_right 2012
-
incorporation-company (2012-07-23) - NEWINC