-
ROUTE 24 LIMITED - 325-327 Oldfield Lane North, Greenford, Middlesex, UB6 0FX, Grossbritannien
Firmenprofil
- Handelsregisternummer
- 08146437
- Firmenstatus
- EINGETRAGEN
- Land
- Grossbritannien
- Protokollierter Sitz
- 325-327 Oldfield Lane North
- Greenford
- Middlesex
- UB6 0FX
- United Kingdom 325-327 Oldfield Lane North, Greenford, Middlesex, UB6 0FX, United Kingdom UK
Management
- Geschäftsführung
- BERRY, Ruth Ann
- CHEEK, Robert Douglas
- LAW, Josephine Rose
- SAMUELSON, Marc Jack Wylie
- Prokuristen
- SAMUELSON, Marc
Firmendetails
- Geschäftszweig
- ltd
- Gründungsdatum
- 17.07.2012
- Alter der Firma 2012-07-17 11 Jahre
- SIC/NACE
- 59113
Eigentumsverhältnisse
- Beneficial Owners
- Mr Marc Jack Wylie Samuelson
Landes-Besonderheiten
- Zusätzliche Statusdetails
- active
- Ehemalige Namen
- RED SPARK PRODUCTIONS LIMITED
- Bilanzhinterlegung
- Fälligkeit: 2021-09-30
- Letzte Einreichung: 2019-12-31
- Jahresmeldung
- Fälligkeit: 2022-07-31
- Letzte Einreichung: 2021-07-17
-
ROUTE 24 LIMITED Firmenbeschreibung
- ROUTE 24 LIMITED ist eine in Grossbritannien als ltd registrierte Firma mit der Register-Nr. 08146437. Ihr derzeitiger Status ist "eingetragen". Die Firma wurde 17.07.2012 registriert. ROUTE 24 LIMITED hat Ihre Tätigkeit zuvor unter dem Namen RED SPARK PRODUCTIONS LIMITED ausgeführt. Das Unternehmen ist mit dem SIC/NACE Code "59113" registriert. Das Unternehmen hat 4 Geschäftsführer und 1 Prokuristen. Die Bilanz wurde zuletzt am 31.12.2019 hinterlegt.Die Firma kann schriftlich über 325-327 Oldfield Lane North erreicht werden.
Jetzt sichern ROUTE 24 LIMITED HandelsregisterauszugJahresabschlussListe der GesellschafterGesellschaftsvertragBeneficial Owners Check
Sie befinden sich hier: Route 24 Limited - 325-327 Oldfield Lane North, Greenford, Middlesex, UB6 0FX, Grossbritannien
- 2012-07-17
- 0-2
- 3-5
- 6-20
- 21-50
- 51+
- Jahre
Haben Sie gewusst? kompany stellt Ihnen amtliche & offizielle Dokumente zu ROUTE 24 LIMITED aus Handelsregister und Firmenbuch im Original zur Verfügung. Das garantieren wir.
Handelsregisterauszug
Amtlicher Nachweis der Existenz des Unternehmens
Jahresabschluss
Finanzdaten zum letzten Berichtsjahr
Liste der Gesellschafter
Angaben zu den Eigentumsverhältnissen
Gesellschaftsvertrag
Gründungsdokumente
Beneficial Owners Check
Angaben über den wirtschaftlichen Eigentümer (Beneficial Owner)
Amtliche Dokumente
Amtliche Dokumente direkt vom offiziellen Handelsregister
keyboard_arrow_down 2021
-
confirmation-statement-with-no-updates (2021-08-21) - CS01
keyboard_arrow_right 2020
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2020-11-19) - AA
-
confirmation-statement-with-no-updates (2020-09-17) - CS01
keyboard_arrow_right 2019
-
confirmation-statement-with-no-updates (2019-08-19) - CS01
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2019-04-01) - AD01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2019-12-10) - AA
keyboard_arrow_right 2018
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2018-10-04) - AA
-
confirmation-statement-with-no-updates (2018-07-17) - CS01
keyboard_arrow_right 2017
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2017-10-10) - AA
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2017-09-18) - AP01
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2017-09-18) - TM01
-
confirmation-statement-with-no-updates (2017-08-03) - CS01
keyboard_arrow_right 2016
-
capital-allotment-shares (2016-05-25) - SH01
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2016-05-26) - AP01
-
capital-name-of-class-of-shares (2016-05-26) - SH08
-
appoint-corporate-director-company-with-name-date (2016-05-26) - AP02
-
mortgage-create-with-deed (2016-05-27) - MR01
-
confirmation-statement-with-updates (2016-08-18) - CS01
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2016-06-23) - AD01
-
change-account-reference-date-company-current-shortened (2016-06-26) - AA01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2016-06-08) - AA
-
resolution (2016-05-24) - RESOLUTIONS
-
mortgage-create-with-deed-with-charge-number-charge-creation-date (2016-05-18) - MR01
-
capital-allotment-shares (2016-03-15) - SH01
-
capital-alter-shares-subdivision (2016-03-15) - SH02
-
resolution (2016-03-15) - RESOLUTIONS
-
accounts-amended-with-accounts-type-total-exemption-small (2016-03-09) - AAMD
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2016-01-05) - TM01
-
certificate-change-of-name-company (2016-01-05) - CERTNM
keyboard_arrow_right 2015
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2015-12-21) - AA
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2015-07-28) - AR01
keyboard_arrow_right 2014
-
certificate-change-of-name-company (2014-11-21) - CERTNM
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2014-08-19) - AP01
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2014-08-06) - AR01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2014-08-04) - AA
-
capital-allotment-shares (2014-04-04) - SH01
keyboard_arrow_right 2013
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2013-07-19) - AR01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2013-05-07) - AA
keyboard_arrow_right 2012
-
incorporation-company (2012-07-17) - NEWINC
-
change-account-reference-date-company-current-shortened (2012-10-23) - AA01