-
PATIENTSOURCE LIMITED - Stirling House Denny End Road, Waterbeach, Cambridge, CB25 9PB, Grossbritannien
Firmenprofil
- Handelsregisternummer
- 08143706
- Firmenstatus
- EINGETRAGEN
- Land
- Grossbritannien
- Protokollierter Sitz
- Stirling House Denny End Road
- Waterbeach
- Cambridge
- CB25 9PB
- United Kingdom Stirling House Denny End Road, Waterbeach, Cambridge, CB25 9PB, United Kingdom UK
Management
- Geschäftsführung
- ASHWORTH, Philip Carr, Dr
- BROOKS, Michael James Thomas, Dr
- MCSWEENEY, Philip John Royston
- Prokuristen
- -
Firmendetails
- Geschäftszweig
- ltd
- Gründungsdatum
- 16.07.2012
- Alter der Firma 2012-07-16 11 Jahre
- SIC/NACE
- 62012
Eigentumsverhältnisse
- Beneficial Owners
- Dr Michael James Thomas Brooks
- -
- Mr Phil Mcsweeney
- -
- Onley Technical Consulting Ltd
- Onley Technical Consulting Ltd
Landes-Besonderheiten
- Zusätzliche Statusdetails
- active
- Bilanzhinterlegung
- Fälligkeit: 2023-04-30
- Letzte Einreichung: 2021-07-31
- Jahresmeldung
- Fälligkeit: 2023-06-17
- Letzte Einreichung: 2022-06-03
-
PATIENTSOURCE LIMITED Firmenbeschreibung
- PATIENTSOURCE LIMITED ist eine in Grossbritannien als ltd registrierte Firma mit der Register-Nr. 08143706. Ihr derzeitiger Status ist "eingetragen". Die Firma wurde 16.07.2012 registriert. Das Unternehmen ist mit dem SIC/NACE Code "62012" registriert. Das Unternehmen hat 3 Geschäftsführer Die Firma kann schriftlich über Stirling House Denny End Road erreicht werden.
Jetzt sichern PATIENTSOURCE LIMITED HandelsregisterauszugJahresabschlussListe der GesellschafterGesellschaftsvertragBeneficial Owners Check
Sie befinden sich hier: Patientsource Limited - Stirling House Denny End Road, Waterbeach, Cambridge, CB25 9PB, Grossbritannien
- 2012-07-16
- 0-2
- 3-5
- 6-20
- 21-50
- 51+
- Jahre
Haben Sie gewusst? kompany stellt Ihnen amtliche & offizielle Dokumente zu PATIENTSOURCE LIMITED aus Handelsregister und Firmenbuch im Original zur Verfügung. Das garantieren wir.
Handelsregisterauszug
Amtlicher Nachweis der Existenz des Unternehmens
Jahresabschluss
Finanzdaten zum letzten Berichtsjahr
Liste der Gesellschafter
Angaben zu den Eigentumsverhältnissen
Gesellschaftsvertrag
Gründungsdokumente
Beneficial Owners Check
Angaben über den wirtschaftlichen Eigentümer (Beneficial Owner)
Amtliche Dokumente
Amtliche Dokumente direkt vom offiziellen Handelsregister
keyboard_arrow_down 2022
-
capital-allotment-shares (2022-02-23) - SH01
-
resolution (2022-03-26) - RESOLUTIONS
-
confirmation-statement-with-updates (2022-06-16) - CS01
keyboard_arrow_right 2021
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2021-05-20) - AA
-
cessation-of-a-person-with-significant-control (2021-01-20) - PSC07
-
cessation-of-a-person-with-significant-control (2021-01-19) - PSC07
-
change-person-director-company-with-change-date (2021-01-21) - CH01
-
capital-allotment-shares (2021-03-16) - SH01
-
confirmation-statement-with-updates (2021-06-16) - CS01
-
change-person-director-company-with-change-date (2021-06-16) - CH01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2021-12-13) - AA
keyboard_arrow_right 2020
-
capital-allotment-shares (2020-05-13) - SH01
-
change-person-director-company-with-change-date (2020-02-18) - CH01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2020-04-30) - AA
-
change-to-a-person-with-significant-control (2020-05-31) - PSC04
-
change-to-a-person-with-significant-control (2020-05-31) - PSC05
-
capital-allotment-shares (2020-12-08) - SH01
-
resolution (2020-12-15) - RESOLUTIONS
-
termination-secretary-company-with-name-termination-date (2020-05-02) - TM02
-
confirmation-statement-with-updates (2020-06-03) - CS01
-
memorandum-articles (2020-11-13) - MA
-
resolution (2020-11-13) - RESOLUTIONS
keyboard_arrow_right 2019
-
confirmation-statement-with-updates (2019-08-19) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2019-06-07) - AA
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2019-03-06) - AD01
keyboard_arrow_right 2018
-
confirmation-statement-with-updates (2018-09-14) - CS01
-
notification-of-a-person-with-significant-control (2018-09-14) - PSC01
-
capital-allotment-shares (2018-08-06) - SH01
-
resolution (2018-08-01) - RESOLUTIONS
-
memorandum-articles (2018-07-05) - MA
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2018-04-30) - AA
keyboard_arrow_right 2017
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2017-04-19) - AA
-
confirmation-statement-with-no-updates (2017-07-27) - CS01
keyboard_arrow_right 2016
-
confirmation-statement-with-updates (2016-07-27) - CS01
keyboard_arrow_right 2015
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2015-09-25) - AA
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2015-04-30) - AA
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2015-08-14) - AR01
keyboard_arrow_right 2014
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2014-08-13) - AR01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2014-04-08) - AA
-
change-person-director-company-with-change-date (2014-02-12) - CH01
-
capital-allotment-shares (2014-02-12) - SH01
-
appoint-person-director-company-with-name (2014-02-12) - AP01
keyboard_arrow_right 2013
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2013-08-13) - AR01
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address (2013-08-12) - AD01
keyboard_arrow_right 2012
-
incorporation-company (2012-07-16) - NEWINC