-
FOOTSTARS C.I.C. - 4 The Greens, Rushmere St. Andrew, Ipswich, IP4 5UT, Grossbritannien
Firmenprofil
- Handelsregisternummer
- 08135241
- Firmenstatus
- EINGETRAGEN
- Land
- Grossbritannien
- Protokollierter Sitz
- 4 The Greens
- Rushmere St. Andrew
- Ipswich
- IP4 5UT 4 The Greens, Rushmere St. Andrew, Ipswich, IP4 5UT UK
Management
- Geschäftsführung
- HAYES, Claire Jane
- HAYES, Guy Alexander
- HAYES, Marc Antony
- HAYES, Martha Rukmani
- Prokuristen
- HAYES, Claire Jane
Firmendetails
- Geschäftszweig
- ltd
- Gründungsdatum
- 09.07.2012
- Alter der Firma 2012-07-09 11 Jahre
- SIC/NACE
- 93120
Eigentumsverhältnisse
- Beneficial Owners
- -
- Mr Guy Alexander Hayes
Landes-Besonderheiten
- Zusätzliche Statusdetails
- active
- Ehemalige Namen
- FOOTSTARS LIMITED
- Bilanzhinterlegung
- Fälligkeit: 2022-04-30
- Letzte Einreichung: 2020-07-31
- Jahresmeldung
- Fälligkeit: 2022-07-23
- Letzte Einreichung: 2021-07-09
-
FOOTSTARS C.I.C. Firmenbeschreibung
- FOOTSTARS C.I.C. ist eine in Grossbritannien als ltd registrierte Firma mit der Register-Nr. 08135241. Ihr derzeitiger Status ist "eingetragen". Die Firma wurde 09.07.2012 registriert. FOOTSTARS C.I.C. hat Ihre Tätigkeit zuvor unter dem Namen FOOTSTARS LIMITED ausgeführt. Das Unternehmen ist mit dem SIC/NACE Code "93120" registriert. Das Unternehmen hat 4 Geschäftsführer und 1 Prokuristen.Die Firma kann schriftlich über 4 The Greens erreicht werden.
Jetzt sichern FOOTSTARS C.I.C. HandelsregisterauszugJahresabschlussListe der GesellschafterGesellschaftsvertragBeneficial Owners Check
Sie befinden sich hier: Footstars C.i.c. - 4 The Greens, Rushmere St. Andrew, Ipswich, IP4 5UT, Grossbritannien
- 2012-07-09
- 0-2
- 3-5
- 6-20
- 21-50
- 51+
- Jahre
Haben Sie gewusst? kompany stellt Ihnen amtliche & offizielle Dokumente zu FOOTSTARS C.I.C. aus Handelsregister und Firmenbuch im Original zur Verfügung. Das garantieren wir.
Handelsregisterauszug
Amtlicher Nachweis der Existenz des Unternehmens
Jahresabschluss
Finanzdaten zum letzten Berichtsjahr
Liste der Gesellschafter
Angaben zu den Eigentumsverhältnissen
Gesellschaftsvertrag
Gründungsdokumente
Beneficial Owners Check
Angaben über den wirtschaftlichen Eigentümer (Beneficial Owner)
Amtliche Dokumente
Amtliche Dokumente direkt vom offiziellen Handelsregister
keyboard_arrow_down 2021
-
withdrawal-of-a-person-with-significant-control-statement (2021-07-28) - PSC09
-
notification-of-a-person-with-significant-control (2021-09-07) - PSC01
-
confirmation-statement-with-no-updates (2021-09-16) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2021-06-11) - AA
keyboard_arrow_right 2020
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2020-08-04) - AA
-
confirmation-statement-with-updates (2020-09-04) - CS01
keyboard_arrow_right 2019
-
confirmation-statement-with-no-updates (2019-07-21) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-dormant (2019-06-14) - AA
keyboard_arrow_right 2018
-
cessation-of-a-person-with-significant-control (2018-03-18) - PSC07
-
notification-of-a-person-with-significant-control-statement (2018-11-04) - PSC08
-
confirmation-statement-with-no-updates (2018-07-22) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-dormant (2018-04-16) - AA
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2018-03-20) - AP01
-
resolution (2018-01-31) - RESOLUTIONS
-
change-of-name-community-interest-company (2018-01-31) - CICCON
-
change-of-name-notice (2018-01-31) - CONNOT
keyboard_arrow_right 2017
-
accounts-with-accounts-type-dormant (2017-04-23) - AA
-
confirmation-statement-with-no-updates (2017-08-23) - CS01
keyboard_arrow_right 2016
-
accounts-with-accounts-type-dormant (2016-06-08) - AA
-
confirmation-statement-with-updates (2016-08-16) - CS01
keyboard_arrow_right 2015
-
accounts-with-accounts-type-dormant (2015-03-27) - AA
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2015-07-26) - AR01
keyboard_arrow_right 2014
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2014-10-07) - AR01
-
accounts-with-accounts-type-dormant (2014-03-30) - AA
-
termination-director-company-with-name (2014-01-09) - TM01
-
dissolution-withdrawal-application-strike-off-company (2014-01-05) - DS02
-
appoint-person-director-company-with-name (2014-01-05) - AP01
keyboard_arrow_right 2013
-
gazette-notice-voluntary (2013-12-31) - GAZ1(A)
-
dissolution-application-strike-off-company (2013-12-20) - DS01
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2013-07-21) - AR01
-
appoint-person-secretary-company-with-name (2013-07-21) - AP03
keyboard_arrow_right 2012
-
incorporation-company (2012-07-09) - NEWINC
-
appoint-person-director-company-with-name (2012-08-28) - AP01
-
change-person-director-company-with-change-date (2012-08-26) - CH01
-
termination-secretary-company-with-name (2012-08-26) - TM02