-
REDX ANTI-INFECTIVES LTD - Mereside, Alderley Park, Macclesfield, SK10 4TG, Grossbritannien
Firmenprofil
- Handelsregisternummer
- 08134798
- Firmenstatus
- EINGETRAGEN
- Land
- Grossbritannien
- Protokollierter Sitz
- Mereside
- Alderley Park
- Macclesfield
- SK10 4TG
- England Mereside, Alderley Park, Macclesfield, SK10 4TG, England UK
Management
- Geschäftsführung
- ANSON, Lisa Mary Whewell
- MEAD, James Robert, Dr
- ROSS, Iain Gladstone
- Prokuristen
- BOOTH, Andrew William
Firmendetails
- Geschäftszweig
- ltd
- Gründungsdatum
- 09.07.2012
- Alter der Firma 2012-07-09 11 Jahre
- SIC/NACE
- 72110
Eigentumsverhältnisse
- Beneficial Owners
- Redx Pharma Plc
Landes-Besonderheiten
- Zusätzliche Statusdetails
- liquidation
- Bilanzhinterlegung
- Fälligkeit: 2021-06-30
- Letzte Einreichung: 2019-09-30
- Jahresmeldung
- Fälligkeit: 2021-07-23
- Letzte Einreichung: 2020-07-09
-
REDX ANTI-INFECTIVES LTD Firmenbeschreibung
- REDX ANTI-INFECTIVES LTD ist eine in Grossbritannien als ltd registrierte Firma mit der Register-Nr. 08134798. Ihr derzeitiger Status ist "eingetragen". Die Firma wurde 09.07.2012 registriert. Das Unternehmen ist mit dem SIC/NACE Code "72110" registriert. Das Unternehmen hat 3 Geschäftsführer und 1 Prokuristen. Die Bilanz wurde zuletzt am 30.09.2019 hinterlegt.Die Firma kann schriftlich über Mereside erreicht werden.
Jetzt sichern REDX ANTI-INFECTIVES LTD HandelsregisterauszugJahresabschlussListe der GesellschafterGesellschaftsvertragBeneficial Owners Check
Sie befinden sich hier: Redx Anti-Infectives Ltd - Mereside, Alderley Park, Macclesfield, SK10 4TG, Grossbritannien
- 2012-07-09
- 0-2
- 3-5
- 6-20
- 21-50
- 51+
- Jahre
Haben Sie gewusst? kompany stellt Ihnen amtliche & offizielle Dokumente zu REDX ANTI-INFECTIVES LTD aus Handelsregister und Firmenbuch im Original zur Verfügung. Das garantieren wir.
Handelsregisterauszug
Amtlicher Nachweis der Existenz des Unternehmens
Jahresabschluss
Finanzdaten zum letzten Berichtsjahr
Liste der Gesellschafter
Angaben zu den Eigentumsverhältnissen
Gesellschaftsvertrag
Gründungsdokumente
Beneficial Owners Check
Angaben über den wirtschaftlichen Eigentümer (Beneficial Owner)
Amtliche Dokumente
Amtliche Dokumente direkt vom offiziellen Handelsregister
keyboard_arrow_down 2021
-
mortgage-satisfy-charge-full (2021-05-19) - MR04
-
capital-allotment-shares (2021-04-23) - SH01
keyboard_arrow_right 2020
-
mortgage-satisfy-charge-full (2020-01-24) - MR04
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2020-02-10) - AP01
-
resolution (2020-07-13) - RESOLUTIONS
-
memorandum-articles (2020-07-13) - MA
-
accounts-with-accounts-type-full (2020-06-02) - AA
-
resolution (2020-04-21) - RESOLUTIONS
-
change-to-a-person-with-significant-control (2020-02-28) - PSC05
-
mortgage-create-with-deed-with-charge-number-charge-creation-date (2020-03-30) - MR01
-
mortgage-satisfy-charge-full (2020-08-10) - MR04
-
confirmation-statement-with-no-updates (2020-07-21) - CS01
-
memorandum-articles (2020-04-07) - MA
-
mortgage-create-with-deed-with-charge-number-charge-creation-date (2020-08-07) - MR01
keyboard_arrow_right 2019
-
confirmation-statement-with-no-updates (2019-07-22) - CS01
-
resolution (2019-07-02) - RESOLUTIONS
-
mortgage-create-with-deed-with-charge-number-charge-creation-date (2019-06-12) - MR01
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2019-03-22) - AP01
-
accounts-with-accounts-type-full (2019-03-21) - AA
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2019-03-05) - TM01
keyboard_arrow_right 2018
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2018-03-05) - AP01
-
confirmation-statement-with-no-updates (2018-07-25) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-full (2018-03-15) - AA
keyboard_arrow_right 2017
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2017-11-07) - AP01
-
appoint-person-secretary-company-with-name-date (2017-09-04) - AP03
-
confirmation-statement-with-no-updates (2017-09-04) - CS01
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2017-09-04) - AD01
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2017-11-07) - TM01
-
termination-secretary-company-with-name-termination-date (2017-09-04) - TM02
-
accounts-with-accounts-type-full (2017-05-31) - AA
keyboard_arrow_right 2016
-
confirmation-statement-with-updates (2016-07-20) - CS01
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2016-07-20) - TM01
-
accounts-with-accounts-type-full (2016-02-08) - AA
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2016-10-04) - TM01
keyboard_arrow_right 2015
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2015-08-27) - TM01
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2015-07-30) - AR01
-
accounts-with-accounts-type-small (2015-02-02) - AA
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2015-08-27) - AP01
keyboard_arrow_right 2014
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2014-07-16) - AR01
-
accounts-with-accounts-type-small (2014-04-14) - AA
keyboard_arrow_right 2013
-
change-account-reference-date-company-current-extended (2013-08-09) - AA01
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2013-07-12) - AR01
-
appoint-person-director-company-with-name (2013-01-18) - AP01
keyboard_arrow_right 2012
-
incorporation-company (2012-07-09) - NEWINC