-
BRIDGETON STEEL STRUCTURES LTD - C/O Geoffrey Martin & Co 3rd Floor, One Park Row, Leeds, LS1 5HN, Grossbritannien
Firmenprofil
- Handelsregisternummer
- 08132879
- Firmenstatus
- GELÖSCHT
- Land
- Grossbritannien
- Protokollierter Sitz
- C/O Geoffrey Martin & Co 3rd Floor
- One Park Row
- Leeds
- LS1 5HN C/O Geoffrey Martin & Co 3rd Floor, One Park Row, Leeds, LS1 5HN UK
Management
- Geschäftsführung
- GARVEY, Brian Richard
- GARVEY, Jacquie Hilary
- Prokuristen
- -
Firmendetails
- Geschäftszweig
- ltd
- Gründungsdatum
- 06.07.2012
- Gelöscht am:
- 2020-04-09
- SIC/NACE
- 43290
Eigentumsverhältnisse
- Beneficial Owners
- Finance Yorkshire Equity
Landes-Besonderheiten
- Zusätzliche Statusdetails
- dissolved
- Ehemalige Namen
- ADAM G BROWN & CO LIMITED
- Bilanzhinterlegung
- Fälligkeit:
- Letzte Einreichung: 2015-12-31
-
BRIDGETON STEEL STRUCTURES LTD Firmenbeschreibung
- BRIDGETON STEEL STRUCTURES LTD ist eine in Grossbritannien als ltd registrierte Firma mit der Register-Nr. 08132879. Ihr derzeitiger Status ist "gelöscht". Die Firma wurde 06.07.2012 registriert. BRIDGETON STEEL STRUCTURES LTD hat Ihre Tätigkeit zuvor unter dem Namen ADAM G BROWN & CO LIMITED ausgeführt. Das Unternehmen ist mit dem SIC/NACE Code "43290" registriert. Das Unternehmen hat 2 Geschäftsführer Die Firma kann schriftlich über C/o Geoffrey Martin & Co 3Rd Floor erreicht werden.
Jetzt sichern BRIDGETON STEEL STRUCTURES LTD HandelsregisterauszugJahresabschlussListe der GesellschafterGesellschaftsvertragBeneficial Owners Check
Sie befinden sich hier: Bridgeton Steel Structures Ltd - C/O Geoffrey Martin & Co 3rd Floor, One Park Row, Leeds, LS1 5HN, Grossbritannien
Haben Sie gewusst? kompany stellt Ihnen amtliche & offizielle Dokumente zu BRIDGETON STEEL STRUCTURES LTD aus Handelsregister und Firmenbuch im Original zur Verfügung. Das garantieren wir.
Handelsregisterauszug
Amtlicher Nachweis der Existenz des Unternehmens
Jahresabschluss
Finanzdaten zum letzten Berichtsjahr
Liste der Gesellschafter
Angaben zu den Eigentumsverhältnissen
Gesellschaftsvertrag
Gründungsdokumente
Beneficial Owners Check
Angaben über den wirtschaftlichen Eigentümer (Beneficial Owner)
Amtliche Dokumente
Amtliche Dokumente direkt vom offiziellen Handelsregister
keyboard_arrow_down 2020
-
gazette-dissolved-liquidation (2020-04-09) - GAZ2
-
liquidation-in-administration-move-to-dissolution (2020-01-09) - AM23
keyboard_arrow_right 2019
-
liquidation-in-administration-progress-report (2019-03-05) - AM10
-
liquidation-in-administration-extension-of-period (2019-03-03) - AM19
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2019-02-12) - AD01
-
liquidation-in-administration-progress-report (2019-08-13) - AM10
keyboard_arrow_right 2018
-
liquidation-in-administration-progress-report (2018-11-21) - AM10
-
liquidation-in-administration-progress-report (2018-02-16) - AM10
-
liquidation-in-administration-extension-of-period (2018-01-15) - AM19
keyboard_arrow_right 2017
-
liquidation-in-administration-proposals (2017-03-17) - 2.17B
-
liquidation-in-administration-appointment-of-administrator (2017-01-24) - 2.12B
-
liquidation-in-administration-progress-report (2017-08-17) - AM10
-
liquidation-administration-notice-deemed-approval-of-proposals (2017-03-31) - F2.18
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2017-01-25) - AD01
keyboard_arrow_right 2016
-
mortgage-satisfy-charge-full (2016-12-22) - MR04
-
termination-secretary-company-with-name-termination-date (2016-12-07) - TM02
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2016-12-07) - TM01
-
accounts-with-accounts-type-small (2016-10-10) - AA
-
mortgage-create-with-deed-with-charge-number-charge-creation-date (2016-10-04) - MR01
-
confirmation-statement-with-updates (2016-09-05) - CS01
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2016-08-15) - TM01
-
capital-allotment-shares (2016-04-07) - SH01
keyboard_arrow_right 2015
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2015-11-09) - AP01
-
appoint-person-secretary-company-with-name-date (2015-11-09) - AP03
-
change-person-director-company-with-change-date (2015-07-21) - CH01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2015-03-27) - AA
-
change-account-reference-date-company-previous-shortened (2015-03-12) - AA01
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2015-03-12) - AD01
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2015-07-21) - AR01
keyboard_arrow_right 2014
-
appoint-person-director-company-with-name (2014-03-10) - AP01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2014-04-09) - AA
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2014-08-29) - AR01
-
mortgage-create-with-deed-with-charge-number-charge-creation-date (2014-11-08) - MR01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2014-10-29) - AA
-
capital-alter-shares-subdivision (2014-12-02) - SH02
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2014-12-02) - TM01
-
resolution (2014-12-02) - RESOLUTIONS
-
capital-name-of-class-of-shares (2014-12-02) - SH08
-
capital-allotment-shares (2014-12-02) - SH01
keyboard_arrow_right 2013
-
change-account-reference-date-company-previous-extended (2013-10-22) - AA01
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2013-07-29) - AR01
-
capital-allotment-shares (2013-04-18) - SH01
-
appoint-person-director-company-with-name (2013-04-18) - AP01
keyboard_arrow_right 2012
-
certificate-change-of-name-company (2012-08-16) - CERTNM
-
change-of-name-notice (2012-08-16) - CONNOT
-
incorporation-company (2012-07-06) - NEWINC