-
WHIZZ FILMS LIMITED - Palladium House, 1-4 Argyll Street, London, W1F 7LD, Grossbritannien
Firmenprofil
- Handelsregisternummer
- 08127442
- Firmenstatus
- EINGETRAGEN
- Land
- Grossbritannien
- Protokollierter Sitz
- Palladium House
- 1-4 Argyll Street
- London
- W1F 7LD
- England Palladium House, 1-4 Argyll Street, London, W1F 7LD, England UK
Management
- Geschäftsführung
- WITTENBERG, Georgi Gideon
Firmendetails
- Geschäftszweig
- ltd
- Gründungsdatum
- 03.07.2012
- Alter der Firma 2012-07-03 11 Jahre
- SIC/NACE
- 96090
Eigentumsverhältnisse
- Beneficial Owners
- Mr Georgi Gideon Wittenberg
- Mr George Weisz
- -
Landes-Besonderheiten
- Zusätzliche Statusdetails
- active
- Ehemalige Namen
- MALCAH PRODUCTIONS LIMITED
- Bilanzhinterlegung
- Fälligkeit: 2021-06-29
- Letzte Einreichung: 2019-09-29
- Jahresmeldung
- Fälligkeit: 2021-07-17
- Letzte Einreichung: 2020-07-03
-
WHIZZ FILMS LIMITED Firmenbeschreibung
- WHIZZ FILMS LIMITED ist eine in Grossbritannien als ltd registrierte Firma mit der Register-Nr. 08127442. Ihr derzeitiger Status ist "eingetragen". Die Firma wurde 03.07.2012 registriert. WHIZZ FILMS LIMITED hat Ihre Tätigkeit zuvor unter dem Namen MALCAH PRODUCTIONS LIMITED ausgeführt. Das Unternehmen ist mit dem SIC/NACE Code "96090" registriert. Das Unternehmen hat 1 Geschäftsführer Die Firma kann schriftlich über Palladium House erreicht werden.
Jetzt sichern WHIZZ FILMS LIMITED HandelsregisterauszugJahresabschlussListe der GesellschafterGesellschaftsvertragBeneficial Owners Check
Sie befinden sich hier: Whizz Films Limited - Palladium House, 1-4 Argyll Street, London, W1F 7LD, Grossbritannien
- 2012-07-03
- 0-2
- 3-5
- 6-20
- 21-50
- 51+
- Jahre
Haben Sie gewusst? kompany stellt Ihnen amtliche & offizielle Dokumente zu WHIZZ FILMS LIMITED aus Handelsregister und Firmenbuch im Original zur Verfügung. Das garantieren wir.
Handelsregisterauszug
Amtlicher Nachweis der Existenz des Unternehmens
Jahresabschluss
Finanzdaten zum letzten Berichtsjahr
Liste der Gesellschafter
Angaben zu den Eigentumsverhältnissen
Gesellschaftsvertrag
Gründungsdokumente
Beneficial Owners Check
Angaben über den wirtschaftlichen Eigentümer (Beneficial Owner)
Amtliche Dokumente
Amtliche Dokumente direkt vom offiziellen Handelsregister
keyboard_arrow_down 2020
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2020-07-14) - AA
-
cessation-of-a-person-with-significant-control (2020-05-04) - PSC07
-
confirmation-statement-with-no-updates (2020-07-13) - CS01
keyboard_arrow_right 2019
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2019-06-26) - AA
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2019-03-29) - TM01
-
confirmation-statement-with-no-updates (2019-07-17) - CS01
keyboard_arrow_right 2018
-
confirmation-statement-with-no-updates (2018-07-10) - CS01
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2018-05-03) - AP01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2018-03-16) - AA
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2018-03-08) - TM01
keyboard_arrow_right 2017
-
confirmation-statement-with-no-updates (2017-07-13) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2017-06-29) - AA
keyboard_arrow_right 2016
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2016-05-03) - AD01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2016-09-30) - AA
-
confirmation-statement-with-updates (2016-08-30) - CS01
-
capital-allotment-shares (2016-08-26) - SH01
-
change-account-reference-date-company-previous-shortened (2016-06-29) - AA01
-
change-person-director-company-with-change-date (2016-05-04) - CH01
-
certificate-change-of-name-company (2016-02-16) - CERTNM
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2016-02-16) - TM01
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2016-02-16) - AP01
keyboard_arrow_right 2015
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2015-07-28) - AR01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2015-06-30) - AA
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2015-04-17) - AD01
keyboard_arrow_right 2014
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2014-10-28) - TM01
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2014-07-29) - AR01
-
change-account-reference-date-company-current-extended (2014-06-26) - AA01
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address (2014-06-25) - AD01
keyboard_arrow_right 2013
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address (2013-07-25) - AD01
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2013-07-31) - AR01
-
change-of-name-notice (2013-11-12) - CONNOT
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2013-12-18) - AA
-
termination-director-company-with-name (2013-11-14) - TM01
-
appoint-person-director-company-with-name (2013-11-14) - AP01
-
certificate-change-of-name-company (2013-11-12) - CERTNM
keyboard_arrow_right 2012
-
legacy (2012-11-06) - MG01
-
incorporation-company (2012-07-03) - NEWINC