-
REGENERSIS (SCS PARTNERSHIP) LIMITED - Ctdi Ltd Featherstone Road, Wolverton Mill, Milton Keynes, MK12 5TH, Grossbritannien
Firmenprofil
- Handelsregisternummer
- 08120808
- Firmenstatus
- GELÖSCHT
- Land
- Grossbritannien
- Protokollierter Sitz
- Ctdi Ltd Featherstone Road
- Wolverton Mill
- Milton Keynes
- MK12 5TH
- United Kingdom Ctdi Ltd Featherstone Road, Wolverton Mill, Milton Keynes, MK12 5TH, United Kingdom UK
Management
- Geschäftsführung
- BULL, Matthew
- HOLLENBACH, Dieter
- RUTH, Monika
- Prokuristen
- CLC SECRETARIAL SERVICES LTD
Firmendetails
- Geschäftszweig
- ltd
- Gründungsdatum
- 27.06.2012
- Gelöscht am:
- 2021-11-30
- SIC/NACE
- 64209
Eigentumsverhältnisse
- Beneficial Owners
- Regenersis (Depot) Services Ltd
Landes-Besonderheiten
- Zusätzliche Statusdetails
- dissolved
- Bilanzhinterlegung
- Fälligkeit: 2021-09-30
- Letzte Einreichung: 2019-12-31
- Jahresmeldung
- Fälligkeit: 2022-07-11
- Letzte Einreichung: 2021-06-27
-
REGENERSIS (SCS PARTNERSHIP) LIMITED Firmenbeschreibung
- REGENERSIS (SCS PARTNERSHIP) LIMITED ist eine in Grossbritannien als ltd registrierte Firma mit der Register-Nr. 08120808. Ihr derzeitiger Status ist "gelöscht". Die Firma wurde 27.06.2012 registriert. Das Unternehmen ist mit dem SIC/NACE Code "64209" registriert. Das Unternehmen hat 3 Geschäftsführer und 1 Prokuristen. Die Bilanz wurde zuletzt am 31.12.2019 hinterlegt.Die Firma kann schriftlich über Ctdi Ltd Featherstone Road erreicht werden.
Jetzt sichern REGENERSIS (SCS PARTNERSHIP) LIMITED HandelsregisterauszugJahresabschlussListe der GesellschafterGesellschaftsvertragBeneficial Owners Check
Sie befinden sich hier: Regenersis (Scs Partnership) Limited - Ctdi Ltd Featherstone Road, Wolverton Mill, Milton Keynes, MK12 5TH, Grossbritannien
Haben Sie gewusst? kompany stellt Ihnen amtliche & offizielle Dokumente zu REGENERSIS (SCS PARTNERSHIP) LIMITED aus Handelsregister und Firmenbuch im Original zur Verfügung. Das garantieren wir.
Handelsregisterauszug
Amtlicher Nachweis der Existenz des Unternehmens
Jahresabschluss
Finanzdaten zum letzten Berichtsjahr
Liste der Gesellschafter
Angaben zu den Eigentumsverhältnissen
Gesellschaftsvertrag
Gründungsdokumente
Beneficial Owners Check
Angaben über den wirtschaftlichen Eigentümer (Beneficial Owner)
Amtliche Dokumente
Amtliche Dokumente direkt vom offiziellen Handelsregister
keyboard_arrow_down 2021
-
gazette-notice-voluntary (2021-09-07) - GAZ1(A)
-
confirmation-statement-with-no-updates (2021-06-29) - CS01
-
dissolution-application-strike-off-company (2021-08-27) - DS01
-
gazette-dissolved-voluntary (2021-11-30) - GAZ2(A)
keyboard_arrow_right 2020
-
accounts-with-accounts-type-dormant (2020-09-24) - AA
-
confirmation-statement-with-no-updates (2020-07-02) - CS01
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2020-01-03) - TM01
keyboard_arrow_right 2019
-
accounts-with-accounts-type-small (2019-09-06) - AA
-
confirmation-statement-with-no-updates (2019-06-28) - CS01
keyboard_arrow_right 2018
-
confirmation-statement-with-no-updates (2018-07-12) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-small (2018-10-03) - AA
-
appoint-corporate-secretary-company-with-name-date (2018-08-02) - AP04
-
termination-secretary-company-with-name-termination-date (2018-08-02) - TM02
keyboard_arrow_right 2017
-
notification-of-a-person-with-significant-control (2017-06-28) - PSC02
-
accounts-with-accounts-type-small (2017-10-07) - AA
-
mortgage-satisfy-charge-full (2017-10-13) - MR04
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2017-12-29) - AP01
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2017-12-29) - AD01
-
confirmation-statement-with-updates (2017-06-27) - CS01
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2017-12-29) - TM01
-
change-account-reference-date-company-previous-extended (2017-01-20) - AA01
keyboard_arrow_right 2016
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2016-11-29) - AD01
-
change-corporate-secretary-company-with-change-date (2016-12-22) - CH04
-
mortgage-create-with-deed-with-charge-number-charge-creation-date (2016-04-20) - MR01
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2016-08-09) - AR01
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2016-04-18) - AP01
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2016-04-15) - TM01
-
mortgage-satisfy-charge-full (2016-04-13) - MR04
-
accounts-with-accounts-type-dormant (2016-04-12) - AA
-
mortgage-create-with-deed-with-charge-number-charge-creation-date (2016-04-08) - MR01
keyboard_arrow_right 2015
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2015-02-10) - AD01
-
change-person-director-company-with-change-date (2015-02-18) - CH01
-
change-person-director-company-with-change-date (2015-06-24) - CH01
-
accounts-with-accounts-type-dormant (2015-03-17) - AA
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2015-07-14) - AR01
-
change-person-director-company-with-change-date (2015-12-02) - CH01
keyboard_arrow_right 2014
-
appoint-corporate-secretary-company-with-name-date (2014-11-26) - AP04
-
termination-secretary-company-with-name-termination-date (2014-11-26) - TM02
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2014-07-23) - AR01
-
miscellaneous (2014-05-12) - MISC
-
miscellaneous (2014-04-24) - MISC
keyboard_arrow_right 2013
-
accounts-with-accounts-type-full (2013-12-20) - AA
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2013-07-22) - AR01
keyboard_arrow_right 2012
-
legacy (2012-12-06) - MG01
-
incorporation-company (2012-06-27) - NEWINC
-
change-person-director-company-with-change-date (2012-10-22) - CH01