-
FRONT FOOT HOSPITALITY LIMITED - FORTIS RECOVERY LIMITED, Grove House Meridians Cross Ocean Village, Southampton, SO14 3TJ, Grossbritannien
Firmenprofil
- Handelsregisternummer
- 08116855
- Firmenstatus
- GELÖSCHT
- Land
- Grossbritannien
- Protokollierter Sitz
- FORTIS RECOVERY LIMITED
- Grove House Meridians Cross Ocean Village
- Southampton
- SO14 3TJ FORTIS RECOVERY LIMITED, Grove House Meridians Cross Ocean Village, Southampton, SO14 3TJ UK
Management
- Geschäftsführung
- GRANT, Steven Thomas
Firmendetails
- Geschäftszweig
- ltd
- Gründungsdatum
- 25.06.2012
- Gelöscht am:
- 2023-01-10
- SIC/NACE
- 70229
Eigentumsverhältnisse
- Beneficial Owners
- -
- Mr Steven Thomas Grant
Landes-Besonderheiten
- Zusätzliche Statusdetails
- dissolved
- Ehemalige Namen
- WHARF LEISURE LIMITED
- Bilanzhinterlegung
- Fälligkeit: 2021-12-31
- Letzte Einreichung: 2020-03-31
- Jahresmeldung
- Fälligkeit: 2022-07-10
- Letzte Einreichung: 2021-06-26
-
FRONT FOOT HOSPITALITY LIMITED Firmenbeschreibung
- FRONT FOOT HOSPITALITY LIMITED ist eine in Grossbritannien als ltd registrierte Firma mit der Register-Nr. 08116855. Ihr derzeitiger Status ist "gelöscht". Die Firma wurde 25.06.2012 registriert. FRONT FOOT HOSPITALITY LIMITED hat Ihre Tätigkeit zuvor unter dem Namen WHARF LEISURE LIMITED ausgeführt. Das Unternehmen ist mit dem SIC/NACE Code "70229" registriert. Das Unternehmen hat 1 Geschäftsführer Die Firma kann schriftlich über Fortis Recovery Limited erreicht werden.
Jetzt sichern FRONT FOOT HOSPITALITY LIMITED HandelsregisterauszugJahresabschlussListe der GesellschafterGesellschaftsvertragBeneficial Owners Check
Sie befinden sich hier: Front Foot Hospitality Limited - FORTIS RECOVERY LIMITED, Grove House Meridians Cross Ocean Village, Southampton, SO14 3TJ, Grossbritannien
Haben Sie gewusst? kompany stellt Ihnen amtliche & offizielle Dokumente zu FRONT FOOT HOSPITALITY LIMITED aus Handelsregister und Firmenbuch im Original zur Verfügung. Das garantieren wir.
Handelsregisterauszug
Amtlicher Nachweis der Existenz des Unternehmens
Jahresabschluss
Finanzdaten zum letzten Berichtsjahr
Liste der Gesellschafter
Angaben zu den Eigentumsverhältnissen
Gesellschaftsvertrag
Gründungsdokumente
Beneficial Owners Check
Angaben über den wirtschaftlichen Eigentümer (Beneficial Owner)
Amtliche Dokumente
Amtliche Dokumente direkt vom offiziellen Handelsregister
keyboard_arrow_down 2021
-
confirmation-statement-with-no-updates (2021-08-09) - CS01
-
liquidation-voluntary-statement-of-affairs (2021-08-28) - LIQ02
-
resolution (2021-08-28) - RESOLUTIONS
-
liquidation-voluntary-appointment-of-liquidator (2021-08-28) - 600
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2021-08-30) - AD01
keyboard_arrow_right 2020
-
confirmation-statement-with-updates (2020-06-26) - CS01
-
confirmation-statement-with-no-updates (2020-05-15) - CS01
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2020-05-15) - AD01
-
confirmation-statement-with-no-updates (2020-05-27) - CS01
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2020-06-17) - TM01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2020-11-10) - AA
keyboard_arrow_right 2019
-
change-person-director-company-with-change-date (2019-12-23) - CH01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2019-12-17) - AA
-
confirmation-statement-with-updates (2019-07-09) - CS01
-
change-to-a-person-with-significant-control (2019-07-01) - PSC04
-
change-to-a-person-with-significant-control (2019-06-28) - PSC04
keyboard_arrow_right 2018
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2018-12-03) - AA
-
confirmation-statement-with-updates (2018-07-10) - CS01
keyboard_arrow_right 2017
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2017-12-14) - AA
-
cessation-of-a-person-with-significant-control (2017-07-26) - PSC07
-
notification-of-a-person-with-significant-control (2017-07-26) - PSC01
-
confirmation-statement-with-updates (2017-07-10) - CS01
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2017-01-16) - AD01
keyboard_arrow_right 2016
-
capital-allotment-shares (2016-05-11) - SH01
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2016-09-01) - AR01
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2016-11-11) - TM01
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2016-12-22) - AP01
-
resolution (2016-04-21) - RESOLUTIONS
-
accounts-with-accounts-type-micro-entity (2016-12-13) - AA
keyboard_arrow_right 2015
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2015-07-20) - AR01
-
accounts-with-accounts-type-micro-entity (2015-11-13) - AA
keyboard_arrow_right 2014
-
accounts-with-accounts-type-dormant (2014-12-24) - AA
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2014-11-08) - AD01
-
change-account-reference-date-company-previous-shortened (2014-08-08) - AA01
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2014-07-07) - AR01
-
accounts-with-accounts-type-dormant (2014-02-28) - AA
-
certificate-change-of-name-company (2014-02-07) - CERTNM
keyboard_arrow_right 2013
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2013-07-12) - AR01
-
termination-director-company-with-name (2013-09-10) - TM01
-
termination-director-company-with-name (2013-10-10) - TM01
-
termination-director-company-with-name (2013-12-10) - TM01
-
capital-allotment-shares (2013-12-10) - SH01
keyboard_arrow_right 2012
-
appoint-person-director-company-with-name (2012-06-29) - AP01
-
incorporation-company (2012-06-25) - NEWINC