-
THE PARK VETERINARY GROUP LIMITED - Friars Gate, 1011 Stratford Road, Shirley, West Midlands, Grossbritannien
Firmenprofil
- Handelsregisternummer
- 08114791
- Firmenstatus
- GELÖSCHT
- Land
- Grossbritannien
- Protokollierter Sitz
- Friars Gate
- 1011 Stratford Road
- Shirley
- West Midlands
- B90 4BN
- United Kingdom Friars Gate, 1011 Stratford Road, Shirley, West Midlands, B90 4BN, United Kingdom UK
Management
- Geschäftsführung
- REIDY, Ray Andrew
Firmendetails
- Geschäftszweig
- ltd
- Gründungsdatum
- 21.06.2012
- Gelöscht am:
- 2023-04-30
- SIC/NACE
- 75000
Eigentumsverhältnisse
- Beneficial Owners
- Linnaeus Group Bidco Limited
Landes-Besonderheiten
- Zusätzliche Statusdetails
- dissolved
- Bilanzhinterlegung
- Fälligkeit: 2020-12-31
- Letzte Einreichung: 2018-12-04
- Jahresmeldung
- Fälligkeit: 2021-07-14
- Letzte Einreichung: 2020-06-30
-
THE PARK VETERINARY GROUP LIMITED Firmenbeschreibung
- THE PARK VETERINARY GROUP LIMITED ist eine in Grossbritannien als ltd registrierte Firma mit der Register-Nr. 08114791. Ihr derzeitiger Status ist "gelöscht". Die Firma wurde 21.06.2012 registriert. Das Unternehmen ist mit dem SIC/NACE Code "75000" registriert. Das Unternehmen hat 1 Geschäftsführer Die Firma kann schriftlich über Friars Gate erreicht werden.
Jetzt sichern THE PARK VETERINARY GROUP LIMITED HandelsregisterauszugJahresabschlussListe der GesellschafterGesellschaftsvertragBeneficial Owners Check
Sie befinden sich hier: The Park Veterinary Group Limited - Friars Gate, 1011 Stratford Road, Shirley, West Midlands, Grossbritannien
Haben Sie gewusst? kompany stellt Ihnen amtliche & offizielle Dokumente zu THE PARK VETERINARY GROUP LIMITED aus Handelsregister und Firmenbuch im Original zur Verfügung. Das garantieren wir.
Handelsregisterauszug
Amtlicher Nachweis der Existenz des Unternehmens
Jahresabschluss
Finanzdaten zum letzten Berichtsjahr
Liste der Gesellschafter
Angaben zu den Eigentumsverhältnissen
Gesellschaftsvertrag
Gründungsdokumente
Beneficial Owners Check
Angaben über den wirtschaftlichen Eigentümer (Beneficial Owner)
Amtliche Dokumente
Amtliche Dokumente direkt vom offiziellen Handelsregister
keyboard_arrow_down 2020
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2020-11-17) - TM01
-
change-account-reference-date-company-previous-extended (2020-05-14) - AA01
-
confirmation-statement-with-no-updates (2020-07-15) - CS01
-
liquidation-voluntary-appointment-of-liquidator (2020-11-02) - 600
-
resolution (2020-11-02) - RESOLUTIONS
-
liquidation-voluntary-declaration-of-solvency (2020-11-02) - LIQ01
keyboard_arrow_right 2019
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2019-01-11) - TM01
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2019-01-14) - AD01
-
change-person-director-company-with-change-date (2019-01-29) - CH01
-
change-sail-address-company-with-new-address (2019-01-30) - AD02
-
move-registers-to-sail-company-with-new-address (2019-02-01) - AD03
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2019-05-31) - TM01
-
change-to-a-person-with-significant-control (2019-06-27) - PSC05
-
change-to-a-person-with-significant-control (2019-07-05) - PSC05
-
change-account-reference-date-company-previous-shortened (2019-03-06) - AA01
-
mortgage-satisfy-charge-full (2019-08-16) - MR04
-
confirmation-statement-with-updates (2019-07-11) - CS01
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2019-10-10) - TM01
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2019-10-10) - AP01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2019-09-02) - AA
keyboard_arrow_right 2018
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2018-12-10) - AP01
-
notification-of-a-person-with-significant-control (2018-12-10) - PSC02
-
withdrawal-of-a-person-with-significant-control-statement (2018-12-10) - PSC09
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2018-12-10) - TM01
-
resolution (2018-12-27) - RESOLUTIONS
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2018-11-22) - AA
-
accounts-with-accounts-type-unaudited-abridged (2018-01-23) - AA
-
confirmation-statement-with-no-updates (2018-07-13) - CS01
keyboard_arrow_right 2017
-
confirmation-statement-with-no-updates (2017-07-12) - CS01
-
change-person-director-company-with-change-date (2017-07-12) - CH01
keyboard_arrow_right 2016
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2016-12-15) - AA
-
confirmation-statement-with-updates (2016-07-14) - CS01
-
change-person-director-company-with-change-date (2016-07-14) - CH01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2016-01-27) - AA
keyboard_arrow_right 2015
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2015-08-14) - AR01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2015-01-14) - AA
keyboard_arrow_right 2014
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2014-08-22) - TM01
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2014-08-22) - AR01
keyboard_arrow_right 2013
-
change-account-reference-date-company-current-extended (2013-07-26) - AA01
-
legacy (2013-01-23) - MG01
-
capital-allotment-shares (2013-03-28) - SH01
-
change-account-reference-date-company-previous-shortened (2013-07-15) - AA01
-
capital-allotment-shares (2013-07-15) - SH01
-
capital-alter-shares-subdivision (2013-07-15) - SH02
-
change-person-director-company-with-change-date (2013-07-22) - CH01
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2013-07-22) - AR01
-
accounts-with-accounts-type-dormant (2013-07-15) - AA
keyboard_arrow_right 2012
-
legacy (2012-12-21) - MG01
-
capital-allotment-shares (2012-12-07) - SH01
-
resolution (2012-11-19) - RESOLUTIONS
-
change-person-director-company-with-change-date (2012-07-04) - CH01
-
incorporation-company (2012-06-21) - NEWINC