-
IMPULSE GLOBAL SOLUTIONS LIMITED - Ash House Church Street, Wymeswold, Loughborough, Leicestershire, Grossbritannien
Firmenprofil
- Handelsregisternummer
- 08112406
- Firmenstatus
- EINGETRAGEN
- Land
- Grossbritannien
- Protokollierter Sitz
- Ash House Church Street
- Wymeswold
- Loughborough
- Leicestershire
- LE12 6TX
- England Ash House Church Street, Wymeswold, Loughborough, Leicestershire, LE12 6TX, England UK
Management
- Geschäftsführung
- DAWKINS, Marie Helen
- Prokuristen
- DAWKINS, Marie Helen
Firmendetails
- Geschäftszweig
- ltd
- Gründungsdatum
- 20.06.2012
- Alter der Firma 2012-06-20 11 Jahre
- SIC/NACE
- 46450
Eigentumsverhältnisse
- Beneficial Owners
- Mrs Siobhan Sear-Mayes
- Mrs Siobhan Sear-Mayes
Landes-Besonderheiten
- Zusätzliche Statusdetails
- liquidation
- Bilanzhinterlegung
- Fälligkeit: 2022-03-31
- Letzte Einreichung: 2020-06-30
- Jahresmeldung
- Fälligkeit: 2021-07-04
- Letzte Einreichung: 2020-06-20
-
IMPULSE GLOBAL SOLUTIONS LIMITED Firmenbeschreibung
- IMPULSE GLOBAL SOLUTIONS LIMITED ist eine in Grossbritannien als ltd registrierte Firma mit der Register-Nr. 08112406. Ihr derzeitiger Status ist "eingetragen". Die Firma wurde 20.06.2012 registriert. Das Unternehmen ist mit dem SIC/NACE Code "46450" registriert. Das Unternehmen hat 1 Geschäftsführer und 1 Prokuristen.Die Firma kann schriftlich über Ash House Church Street erreicht werden.
Jetzt sichern IMPULSE GLOBAL SOLUTIONS LIMITED HandelsregisterauszugJahresabschlussListe der GesellschafterGesellschaftsvertragBeneficial Owners Check
Sie befinden sich hier: Impulse Global Solutions Limited - Ash House Church Street, Wymeswold, Loughborough, Leicestershire, Grossbritannien
- 2012-06-20
- 0-2
- 3-5
- 6-20
- 21-50
- 51+
- Jahre
Haben Sie gewusst? kompany stellt Ihnen amtliche & offizielle Dokumente zu IMPULSE GLOBAL SOLUTIONS LIMITED aus Handelsregister und Firmenbuch im Original zur Verfügung. Das garantieren wir.
Handelsregisterauszug
Amtlicher Nachweis der Existenz des Unternehmens
Jahresabschluss
Finanzdaten zum letzten Berichtsjahr
Liste der Gesellschafter
Angaben zu den Eigentumsverhältnissen
Gesellschaftsvertrag
Gründungsdokumente
Beneficial Owners Check
Angaben über den wirtschaftlichen Eigentümer (Beneficial Owner)
Amtliche Dokumente
Amtliche Dokumente direkt vom offiziellen Handelsregister
keyboard_arrow_down 2021
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2021-04-23) - AA
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2021-03-15) - AD01
keyboard_arrow_right 2020
-
change-person-director-company-with-change-date (2020-07-15) - CH01
-
confirmation-statement-with-no-updates (2020-06-25) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2020-03-26) - AA
keyboard_arrow_right 2019
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2019-11-15) - TM01
-
confirmation-statement-with-no-updates (2019-06-25) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2019-03-21) - AA
keyboard_arrow_right 2018
-
confirmation-statement-with-no-updates (2018-07-04) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2018-02-28) - AA
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2018-02-14) - AP01
keyboard_arrow_right 2017
-
confirmation-statement-with-no-updates (2017-06-30) - CS01
-
notification-of-a-person-with-significant-control (2017-06-30) - PSC01
keyboard_arrow_right 2016
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2016-11-23) - AA
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2016-02-04) - AA
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2016-07-25) - AR01
keyboard_arrow_right 2015
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2015-08-27) - AR01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2015-04-16) - AA
keyboard_arrow_right 2014
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2014-10-28) - AP01
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2014-07-21) - AR01
keyboard_arrow_right 2013
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2013-11-05) - AA
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2013-08-28) - AR01
keyboard_arrow_right 2012
-
appoint-person-secretary-company-with-name (2012-07-23) - AP03
-
appoint-person-director-company-with-name (2012-07-23) - AP01
-
termination-secretary-company-with-name (2012-07-23) - TM02
-
termination-director-company-with-name (2012-07-23) - TM01
-
incorporation-company (2012-06-20) - NEWINC