-
WATERLOO (MOTOR TRADE) HOLDINGS LIMITED - Centenary House Peninsula, Rydon Lane, Exeter, EX2 7XE, Grossbritannien
Firmenprofil
- Handelsregisternummer
- 08111840
- Firmenstatus
- GELÖSCHT
- Land
- Grossbritannien
- Protokollierter Sitz
- Centenary House Peninsula
- Rydon Lane
- Exeter
- EX2 7XE Centenary House Peninsula, Rydon Lane, Exeter, EX2 7XE UK
Management
- Geschäftsführung
- CROXSON, Neil Michael
- Prokuristen
- JUNEAU, Louis
Firmendetails
- Geschäftszweig
- ltd
- Gründungsdatum
- 19.06.2012
- Gelöscht am:
- 2022-09-27
- SIC/NACE
- 64209
Eigentumsverhältnisse
- Beneficial Owners
- Pa Group Holdings Limited
Landes-Besonderheiten
- Zusätzliche Statusdetails
- dissolved
- Ehemalige Namen
- SJP71 LIMITED
- Bilanzhinterlegung
- Fälligkeit: 2018-09-30
- Letzte Einreichung: 2016-11-30
- Jahresmeldung
- Fälligkeit: 2018-07-03
- Letzte Einreichung: 2017-06-19
-
WATERLOO (MOTOR TRADE) HOLDINGS LIMITED Firmenbeschreibung
- WATERLOO (MOTOR TRADE) HOLDINGS LIMITED ist eine in Grossbritannien als ltd registrierte Firma mit der Register-Nr. 08111840. Ihr derzeitiger Status ist "gelöscht". Die Firma wurde 19.06.2012 registriert. WATERLOO (MOTOR TRADE) HOLDINGS LIMITED hat Ihre Tätigkeit zuvor unter dem Namen SJP71 LIMITED ausgeführt. Das Unternehmen ist mit dem SIC/NACE Code "64209" registriert. Das Unternehmen hat 1 Geschäftsführer und 1 Prokuristen. Die Bilanz wurde zuletzt am 30.11.2016 hinterlegt.Die Firma kann schriftlich über Centenary House Peninsula erreicht werden.
Jetzt sichern WATERLOO (MOTOR TRADE) HOLDINGS LIMITED HandelsregisterauszugJahresabschlussListe der GesellschafterGesellschaftsvertragBeneficial Owners Check
Sie befinden sich hier: Waterloo (Motor Trade) Holdings Limited - Centenary House Peninsula, Rydon Lane, Exeter, EX2 7XE, Grossbritannien
Haben Sie gewusst? kompany stellt Ihnen amtliche & offizielle Dokumente zu WATERLOO (MOTOR TRADE) HOLDINGS LIMITED aus Handelsregister und Firmenbuch im Original zur Verfügung. Das garantieren wir.
Handelsregisterauszug
Amtlicher Nachweis der Existenz des Unternehmens
Jahresabschluss
Finanzdaten zum letzten Berichtsjahr
Liste der Gesellschafter
Angaben zu den Eigentumsverhältnissen
Gesellschaftsvertrag
Gründungsdokumente
Beneficial Owners Check
Angaben über den wirtschaftlichen Eigentümer (Beneficial Owner)
Amtliche Dokumente
Amtliche Dokumente direkt vom offiziellen Handelsregister
keyboard_arrow_down 2021
-
liquidation-voluntary-statement-of-receipts-and-payments-with-brought-down-date (2021-04-07) - LIQ03
keyboard_arrow_right 2020
-
liquidation-voluntary-statement-of-receipts-and-payments-with-brought-down-date (2020-04-16) - LIQ03
keyboard_arrow_right 2019
-
liquidation-voluntary-statement-of-receipts-and-payments-with-brought-down-date (2019-04-08) - LIQ03
keyboard_arrow_right 2018
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2018-04-19) - AD01
-
liquidation-voluntary-appointment-of-liquidator (2018-03-13) - 600
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2018-02-21) - AD01
-
resolution (2018-02-19) - RESOLUTIONS
-
liquidation-voluntary-declaration-of-solvency (2018-02-19) - LIQ01
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2018-02-08) - TM01
keyboard_arrow_right 2017
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2017-02-08) - AD01
-
change-account-reference-date-company-previous-shortened (2017-03-24) - AA01
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2017-04-07) - TM01
-
notification-of-a-person-with-significant-control (2017-06-29) - PSC02
-
confirmation-statement-with-updates (2017-06-29) - CS01
-
gazette-filings-brought-up-to-date (2017-11-14) - DISS40
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2017-08-18) - AP01
-
gazette-notice-compulsory (2017-10-31) - GAZ1
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2017-12-01) - AA
-
appoint-person-secretary-company-with-name-date (2017-08-18) - AP03
-
change-account-reference-date-company-current-extended (2017-11-22) - AA01
keyboard_arrow_right 2016
-
termination-secretary-company-with-name-termination-date (2016-12-29) - TM02
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2016-12-29) - AP01
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2016-12-29) - TM01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2016-07-28) - AA
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2016-07-17) - AR01
keyboard_arrow_right 2015
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2015-09-26) - AA
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2015-07-13) - AR01
-
change-account-reference-date-company-previous-extended (2015-03-23) - AA01
keyboard_arrow_right 2014
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2014-07-17) - AR01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2014-03-17) - AA
keyboard_arrow_right 2013
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2013-07-05) - AR01
-
appoint-person-secretary-company-with-name (2013-01-14) - AP03
keyboard_arrow_right 2012
-
change-of-name-notice (2012-11-22) - CONNOT
-
resolution (2012-11-22) - RESOLUTIONS
-
certificate-change-of-name-company (2012-12-04) - CERTNM
-
resolution (2012-12-17) - RESOLUTIONS
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address (2012-12-17) - AD01
-
termination-director-company-with-name (2012-12-18) - TM01
-
appoint-person-director-company-with-name (2012-12-18) - AP01
-
termination-secretary-company-with-name (2012-12-18) - TM02
-
capital-allotment-shares (2012-12-17) - SH01
-
incorporation-company (2012-06-19) - NEWINC