-
ACOMB MEDICAL LIMITED - 199 Acomb Road, Acomb, York, YO24 4HD, Grossbritannien
Firmenprofil
- Handelsregisternummer
- 08083723
- Firmenstatus
- EINGETRAGEN
- Land
- Grossbritannien
- Protokollierter Sitz
- 199 Acomb Road
- Acomb
- York
- YO24 4HD 199 Acomb Road, Acomb, York, YO24 4HD UK
Management
- Geschäftsführung
- DREWERY, Iain Richard
- FIELD, Rebecca, Dr
- INWOOD, Jane Louise, Dr
- MARSDEN, Richard Stephen
- Prokuristen
- -
Firmendetails
- Geschäftszweig
- ltd
- Gründungsdatum
- 25.05.2012
- Alter der Firma 2012-05-25 12 Jahre
- SIC/NACE
- 86900
Eigentumsverhältnisse
- Beneficial Owners
- -
- Drewery Medical Limited
- Ymg Acomb Medical Ltd
Landes-Besonderheiten
- Zusätzliche Statusdetails
- Active
- Bilanzhinterlegung
- Fälligkeit: 2025-03-31
- Letzte Einreichung: 2023-06-30
- Jahresmeldung
- Fälligkeit: 2025-04-17
- Letzte Einreichung: 2024-04-03
-
ACOMB MEDICAL LIMITED Firmenbeschreibung
- ACOMB MEDICAL LIMITED ist eine in Grossbritannien als ltd registrierte Firma mit der Register-Nr. 08083723. Ihr derzeitiger Status ist "eingetragen". Die Firma wurde 25.05.2012 registriert. Das Unternehmen ist mit dem SIC/NACE Code "86900" registriert. Das Unternehmen hat 4 Geschäftsführer Die Firma kann schriftlich über 199 Acomb Road erreicht werden.
Jetzt sichern ACOMB MEDICAL LIMITED HandelsregisterauszugJahresabschlussListe der GesellschafterGesellschaftsvertragBeneficial Owners Check
Sie befinden sich hier: Acomb Medical Limited - 199 Acomb Road, Acomb, York, YO24 4HD, Grossbritannien
- 2012-05-25
- 0-2
- 3-5
- 6-20
- 21-50
- 51+
- Jahre
Haben Sie gewusst? kompany stellt Ihnen amtliche & offizielle Dokumente zu ACOMB MEDICAL LIMITED aus Handelsregister und Firmenbuch im Original zur Verfügung. Das garantieren wir.
Handelsregisterauszug
Amtlicher Nachweis der Existenz des Unternehmens
Jahresabschluss
Finanzdaten zum letzten Berichtsjahr
Liste der Gesellschafter
Angaben zu den Eigentumsverhältnissen
Gesellschaftsvertrag
Gründungsdokumente
Beneficial Owners Check
Angaben über den wirtschaftlichen Eigentümer (Beneficial Owner)
Amtliche Dokumente
Amtliche Dokumente direkt vom offiziellen Handelsregister
keyboard_arrow_down 2024
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2024-03-25) - AA
-
confirmation-statement-with-updates (2024-04-26) - CS01
keyboard_arrow_right 2023
-
confirmation-statement-with-no-updates (2023-04-20) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2023-03-17) - AA
keyboard_arrow_right 2022
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2022-03-25) - AA
-
confirmation-statement-with-updates (2022-04-19) - CS01
keyboard_arrow_right 2021
-
cessation-of-a-person-with-significant-control (2021-04-22) - PSC07
-
notification-of-a-person-with-significant-control (2021-04-22) - PSC02
-
confirmation-statement-with-updates (2021-04-22) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2021-06-03) - AA
keyboard_arrow_right 2020
-
confirmation-statement-with-updates (2020-05-07) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2020-03-31) - AA
keyboard_arrow_right 2019
-
mortgage-create-with-deed-with-charge-number-charge-creation-date (2019-07-16) - MR01
-
confirmation-statement-with-updates (2019-04-03) - CS01
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2019-07-30) - TM01
-
notification-of-a-person-with-significant-control (2019-07-30) - PSC02
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2019-07-30) - AP01
keyboard_arrow_right 2018
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2018-11-07) - AA
-
confirmation-statement-with-updates (2018-05-30) - CS01
keyboard_arrow_right 2017
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2017-09-13) - AA
-
notification-of-a-person-with-significant-control (2017-07-07) - PSC01
-
confirmation-statement-with-updates (2017-06-28) - CS01
keyboard_arrow_right 2016
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2016-10-21) - AA
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2016-03-03) - AA
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2016-06-20) - AR01
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2016-05-25) - TM01
keyboard_arrow_right 2015
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2015-03-31) - AA
-
resolution (2015-10-05) - RESOLUTIONS
-
capital-allotment-shares (2015-06-24) - SH01
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2015-06-15) - AR01
keyboard_arrow_right 2014
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2014-06-20) - AR01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2014-03-04) - AA
keyboard_arrow_right 2013
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2013-06-19) - AR01
-
change-account-reference-date-company-current-extended (2013-02-14) - AA01
-
legacy (2013-01-26) - MG01
keyboard_arrow_right 2012
-
appoint-person-secretary-company-with-name (2012-06-29) - AP03
-
appoint-person-director-company-with-name (2012-06-29) - AP01
-
termination-secretary-company-with-name (2012-11-27) - TM02
-
termination-director-company-with-name (2012-11-27) - TM01
-
appoint-person-director-company-with-name (2012-11-27) - AP01
-
legacy (2012-12-19) - MG01
-
appoint-person-director-company-with-name (2012-11-28) - AP01
-
termination-director-company-with-name (2012-06-29) - TM01
-
legacy (2012-12-28) - MG01
-
incorporation-company (2012-05-25) - NEWINC