-
CEROS CROWD FUSION LTD - Broadgate Tower, 20 Primrose Street, 12th Floor, London, EC2A 2EW, Grossbritannien
Firmenprofil
- Handelsregisternummer
- 08072123
- Firmenstatus
- EINGETRAGEN
- Land
- Grossbritannien
- Protokollierter Sitz
- Broadgate Tower
- 20 Primrose Street, 12th Floor
- London
- EC2A 2EW
- England Broadgate Tower, 20 Primrose Street, 12th Floor, London, EC2A 2EW, England UK
Management
- Geschäftsführung
- BERG, Simon James
- Prokuristen
- BENDER, Robert
Firmendetails
- Geschäftszweig
- ltd
- Gründungsdatum
- 16.05.2012
- Alter der Firma 2012-05-16 12 Jahre
- SIC/NACE
- 62012
Eigentumsverhältnisse
- Beneficial Owners
- Mr. Simon James Berg
Landes-Besonderheiten
- Zusätzliche Statusdetails
- active
- Ehemalige Namen
- SHB1 LTD
- Bilanzhinterlegung
- Fälligkeit: 2021-09-30
- Letzte Einreichung: 2019-12-31
- Jahresmeldung
- Fälligkeit: 2022-05-30
- Letzte Einreichung: 2021-05-16
-
CEROS CROWD FUSION LTD Firmenbeschreibung
- CEROS CROWD FUSION LTD ist eine in Grossbritannien als ltd registrierte Firma mit der Register-Nr. 08072123. Ihr derzeitiger Status ist "eingetragen". Die Firma wurde 16.05.2012 registriert. CEROS CROWD FUSION LTD hat Ihre Tätigkeit zuvor unter dem Namen SHB1 LTD ausgeführt. Das Unternehmen ist mit dem SIC/NACE Code "62012" registriert. Das Unternehmen hat 1 Geschäftsführer und 1 Prokuristen.Die Firma kann schriftlich über Broadgate Tower erreicht werden.
Jetzt sichern CEROS CROWD FUSION LTD HandelsregisterauszugJahresabschlussListe der GesellschafterGesellschaftsvertragBeneficial Owners Check
Sie befinden sich hier: Ceros Crowd Fusion Ltd - Broadgate Tower, 20 Primrose Street, 12th Floor, London, EC2A 2EW, Grossbritannien
- 2012-05-16
- 0-2
- 3-5
- 6-20
- 21-50
- 51+
- Jahre
Haben Sie gewusst? kompany stellt Ihnen amtliche & offizielle Dokumente zu CEROS CROWD FUSION LTD aus Handelsregister und Firmenbuch im Original zur Verfügung. Das garantieren wir.
Handelsregisterauszug
Amtlicher Nachweis der Existenz des Unternehmens
Jahresabschluss
Finanzdaten zum letzten Berichtsjahr
Liste der Gesellschafter
Angaben zu den Eigentumsverhältnissen
Gesellschaftsvertrag
Gründungsdokumente
Beneficial Owners Check
Angaben über den wirtschaftlichen Eigentümer (Beneficial Owner)
Amtliche Dokumente
Amtliche Dokumente direkt vom offiziellen Handelsregister
keyboard_arrow_down 2021
-
move-registers-to-sail-company-with-new-address (2021-06-17) - AD03
-
confirmation-statement-with-no-updates (2021-06-17) - CS01
keyboard_arrow_right 2020
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2020-05-13) - AA
-
confirmation-statement-with-no-updates (2020-06-01) - CS01
keyboard_arrow_right 2019
-
appoint-person-secretary-company-with-name-date (2019-08-29) - AP03
-
confirmation-statement-with-no-updates (2019-08-26) - CS01
-
termination-secretary-company-with-name-termination-date (2019-08-26) - TM02
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2019-07-01) - AA
-
notification-of-a-person-with-significant-control (2019-04-12) - PSC01
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2019-02-04) - AD01
keyboard_arrow_right 2018
-
move-registers-to-sail-company-with-new-address (2018-05-30) - AD03
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2018-06-11) - AD01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2018-06-04) - AA
-
confirmation-statement-with-no-updates (2018-05-30) - CS01
keyboard_arrow_right 2017
-
confirmation-statement-with-no-updates (2017-08-01) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2017-04-13) - AA
keyboard_arrow_right 2016
-
change-sail-address-company-with-new-address (2016-08-12) - AD02
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2016-08-12) - AR01
-
gazette-notice-compulsory (2016-08-16) - GAZ1
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2016-04-29) - TM01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2016-05-06) - AA
-
gazette-filings-brought-up-to-date (2016-08-17) - DISS40
keyboard_arrow_right 2015
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2015-08-17) - AA
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2015-06-23) - AR01
-
appoint-person-secretary-company-with-name-date (2015-06-23) - AP03
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2015-05-22) - TM01
-
termination-secretary-company-with-name-termination-date (2015-05-22) - TM02
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2015-05-22) - AP01
keyboard_arrow_right 2014
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2014-07-18) - AA
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2014-06-04) - AR01
keyboard_arrow_right 2013
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2013-06-12) - AR01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2013-10-09) - AA
-
change-account-reference-date-company-previous-shortened (2013-08-22) - AA01
-
appoint-person-secretary-company-with-name-date (2013-06-11) - AP03
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2013-06-11) - TM01
-
capital-allotment-shares (2013-06-11) - SH01
-
mortgage-create-with-deed-with-charge-number-charge-creation-date (2013-05-24) - MR01
keyboard_arrow_right 2012
-
termination-secretary-company-with-name-termination-date (2012-07-09) - TM02
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2012-07-09) - AP01
-
incorporation-company (2012-05-16) - NEWINC
-
certificate-change-of-name-company (2012-05-21) - CERTNM
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2012-07-09) - TM01