-
THE ITALIAN PLUMBER LTD. - 2 Printer's Yard, 90a The Broadway, London, SW19 1RD, Grossbritannien
Firmenprofil
- Handelsregisternummer
- 08055902
- Firmenstatus
- EINGETRAGEN
- Land
- Grossbritannien
- Protokollierter Sitz
- 2 Printer's Yard
- 90a The Broadway
- London
- SW19 1RD
- England 2 Printer's Yard, 90a The Broadway, London, SW19 1RD, England UK
Management
- Geschäftsführung
- ALBERTON, Samuele
- Prokuristen
- -
Firmendetails
- Geschäftszweig
- ltd
- Gründungsdatum
- 03.05.2012
- Alter der Firma 2012-05-03 12 Jahre
- SIC/NACE
- 74909
Eigentumsverhältnisse
- Beneficial Owners
- Mr Samuele Alberton
- Cassius In The House Ltd
Landes-Besonderheiten
- Zusätzliche Statusdetails
- Active
- Ehemalige Namen
- REEMSHORE LIMITED
- Bilanzhinterlegung
- Fälligkeit: 2025-02-28
- Letzte Einreichung: 2023-05-31
- Jahresmeldung
- Fälligkeit: 2024-12-01
- Letzte Einreichung: 2023-11-17
-
THE ITALIAN PLUMBER LTD. Firmenbeschreibung
- THE ITALIAN PLUMBER LTD. ist eine in Grossbritannien als ltd registrierte Firma mit der Register-Nr. 08055902. Ihr derzeitiger Status ist "eingetragen". Die Firma wurde 03.05.2012 registriert. THE ITALIAN PLUMBER LTD. hat Ihre Tätigkeit zuvor unter dem Namen REEMSHORE LIMITED ausgeführt. Das Unternehmen ist mit dem SIC/NACE Code "74909" registriert. Das Unternehmen hat 1 Geschäftsführer Die Firma kann schriftlich über 2 Printer's Yard erreicht werden.
Jetzt sichern THE ITALIAN PLUMBER LTD. HandelsregisterauszugJahresabschlussListe der GesellschafterGesellschaftsvertragBeneficial Owners Check
Sie befinden sich hier: The Italian Plumber Ltd. - 2 Printer's Yard, 90a The Broadway, London, SW19 1RD, Grossbritannien
- 2012-05-03
- 0-2
- 3-5
- 6-20
- 21-50
- 51+
- Jahre
Haben Sie gewusst? kompany stellt Ihnen amtliche & offizielle Dokumente zu THE ITALIAN PLUMBER LTD. aus Handelsregister und Firmenbuch im Original zur Verfügung. Das garantieren wir.
Handelsregisterauszug
Amtlicher Nachweis der Existenz des Unternehmens
Jahresabschluss
Finanzdaten zum letzten Berichtsjahr
Liste der Gesellschafter
Angaben zu den Eigentumsverhältnissen
Gesellschaftsvertrag
Gründungsdokumente
Beneficial Owners Check
Angaben über den wirtschaftlichen Eigentümer (Beneficial Owner)
Amtliche Dokumente
Amtliche Dokumente direkt vom offiziellen Handelsregister
keyboard_arrow_down 2024
-
accounts-with-accounts-type-micro-entity (2024-02-13) - AA
keyboard_arrow_right 2023
-
accounts-with-accounts-type-micro-entity (2023-02-24) - AA
-
confirmation-statement-with-updates (2023-11-27) - CS01
keyboard_arrow_right 2022
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2022-05-31) - AD01
-
notification-of-a-person-with-significant-control (2022-08-09) - PSC02
-
memorandum-articles (2022-08-10) - MA
-
resolution (2022-08-10) - RESOLUTIONS
-
change-to-a-person-with-significant-control (2022-08-10) - PSC04
-
capital-allotment-shares (2022-08-10) - SH01
-
confirmation-statement-with-updates (2022-11-18) - CS01
keyboard_arrow_right 2021
-
accounts-with-accounts-type-micro-entity (2021-03-12) - AA
-
accounts-with-accounts-type-micro-entity (2021-08-26) - AA
-
confirmation-statement-with-no-updates (2021-11-19) - CS01
keyboard_arrow_right 2020
-
confirmation-statement-with-no-updates (2020-12-22) - CS01
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2020-05-14) - AD01
-
accounts-with-accounts-type-micro-entity (2020-02-10) - AA
keyboard_arrow_right 2019
-
confirmation-statement-with-updates (2019-11-18) - CS01
keyboard_arrow_right 2018
-
confirmation-statement-with-updates (2018-11-19) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-micro-entity (2018-10-24) - AA
-
accounts-with-accounts-type-micro-entity (2018-02-26) - AA
keyboard_arrow_right 2017
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2017-01-30) - AA
-
confirmation-statement-with-updates (2017-11-20) - CS01
keyboard_arrow_right 2016
-
change-person-director-company-with-change-date (2016-11-18) - CH01
-
confirmation-statement-with-updates (2016-11-25) - CS01
-
capital-allotment-shares (2016-02-17) - SH01
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2016-02-17) - AP01
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2016-11-18) - TM01
-
change-person-director-company-with-change-date (2016-11-21) - CH01
-
change-person-director-company-with-change-date (2016-11-24) - CH01
keyboard_arrow_right 2015
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2015-11-17) - AR01
-
change-person-director-company-with-change-date (2015-11-17) - CH01
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2015-02-25) - AD01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2015-12-03) - AA
keyboard_arrow_right 2014
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2014-12-01) - AR01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2014-07-17) - AA
-
accounts-amended-with-made-up-date (2014-06-11) - AAMD
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2014-05-13) - AR01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2014-02-07) - AA
keyboard_arrow_right 2013
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2013-05-06) - AR01
keyboard_arrow_right 2012
-
certificate-change-of-name-company (2012-08-20) - CERTNM
-
resolution (2012-09-05) - RESOLUTIONS
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address (2012-08-30) - AD01
-
appoint-person-director-company-with-name (2012-08-22) - AP01
-
incorporation-company (2012-05-03) - NEWINC
-
termination-secretary-company-with-name (2012-08-22) - TM02
-
termination-director-company-with-name (2012-08-22) - TM01