-
FIZZ PORTRAITS LIMITED - 9-11 Stratford Road, Shirley, Solihull, B90 3LU, Grossbritannien
Firmenprofil
- Handelsregisternummer
- 08017267
- Firmenstatus
- EINGETRAGEN
- Land
- Grossbritannien
- Protokollierter Sitz
- 9-11 Stratford Road
- Shirley
- Solihull
- B90 3LU
- England 9-11 Stratford Road, Shirley, Solihull, B90 3LU, England UK
Management
- Geschäftsführung
- MCGILL, Sarah Jane
Firmendetails
- Geschäftszweig
- ltd
- Gründungsdatum
- 03.04.2012
- Alter der Firma 2012-04-03 12 Jahre
- SIC/NACE
- 74201
Eigentumsverhältnisse
- Beneficial Owners
- Mr Jamie Mcgill
- Mrs Sarah Jane Mcgill
- Mr Robert Bryce Mcgill
- Mr Jamie Mcgill
- Mrs Sarah Mcgill
- Mr Robert Mcgill
- Mr James Robert Mcgill
Landes-Besonderheiten
- Zusätzliche Statusdetails
- Active
- Bilanzhinterlegung
- Fälligkeit: 2025-01-31
- Letzte Einreichung: 2023-04-30
- lezte Bilanzhinterlegung
- 2013-04-03
- Jahresmeldung
- Fälligkeit: 2025-04-17
- Letzte Einreichung: 2024-04-03
-
FIZZ PORTRAITS LIMITED Firmenbeschreibung
- FIZZ PORTRAITS LIMITED ist eine in Grossbritannien als ltd registrierte Firma mit der Register-Nr. 08017267. Ihr derzeitiger Status ist "eingetragen". Die Firma wurde 03.04.2012 registriert. Das Unternehmen ist mit dem SIC/NACE Code "74201" registriert. Das Unternehmen hat 1 Geschäftsführer Die jährliche Meldung erfolgte zuletzt am 03.04.2013.Die Firma kann schriftlich über 9-11 Stratford Road erreicht werden.
Jetzt sichern FIZZ PORTRAITS LIMITED HandelsregisterauszugJahresabschlussListe der GesellschafterGesellschaftsvertragBeneficial Owners Check
Sie befinden sich hier: Fizz Portraits Limited - 9-11 Stratford Road, Shirley, Solihull, B90 3LU, Grossbritannien
- 2012-04-03
- 0-2
- 3-5
- 6-20
- 21-50
- 51+
- Jahre
Haben Sie gewusst? kompany stellt Ihnen amtliche & offizielle Dokumente zu FIZZ PORTRAITS LIMITED aus Handelsregister und Firmenbuch im Original zur Verfügung. Das garantieren wir.
Handelsregisterauszug
Amtlicher Nachweis der Existenz des Unternehmens
Jahresabschluss
Finanzdaten zum letzten Berichtsjahr
Liste der Gesellschafter
Angaben zu den Eigentumsverhältnissen
Gesellschaftsvertrag
Gründungsdokumente
Beneficial Owners Check
Angaben über den wirtschaftlichen Eigentümer (Beneficial Owner)
Amtliche Dokumente
Amtliche Dokumente direkt vom offiziellen Handelsregister
keyboard_arrow_down 2024
-
confirmation-statement-with-no-updates (2024-06-04) - CS01
keyboard_arrow_right 2023
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2023-01-30) - AA
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2023-12-14) - AA
-
change-to-a-person-with-significant-control (2023-11-12) - PSC04
-
change-person-director-company-with-change-date (2023-11-12) - CH01
-
confirmation-statement-with-no-updates (2023-05-15) - CS01
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2023-03-31) - AD01
keyboard_arrow_right 2022
-
confirmation-statement-with-no-updates (2022-04-22) - CS01
keyboard_arrow_right 2021
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2021-02-02) - AA
-
change-to-a-person-with-significant-control (2021-06-09) - PSC04
-
confirmation-statement-with-updates (2021-06-08) - CS01
-
change-to-a-person-with-significant-control (2021-06-08) - PSC04
-
change-person-director-company-with-change-date (2021-06-08) - CH01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2021-10-18) - AA
keyboard_arrow_right 2020
-
mortgage-create-with-deed-with-charge-number-charge-creation-date (2020-07-17) - MR01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2020-01-29) - AA
-
confirmation-statement-with-no-updates (2020-04-20) - CS01
keyboard_arrow_right 2019
-
confirmation-statement-with-no-updates (2019-04-16) - CS01
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2019-10-08) - TM01
keyboard_arrow_right 2018
-
confirmation-statement-with-no-updates (2018-04-13) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2018-01-30) - AA
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2018-12-07) - AA
keyboard_arrow_right 2017
-
confirmation-statement-with-updates (2017-04-18) - CS01
-
change-person-director-company-with-change-date (2017-03-26) - CH01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2017-01-30) - AA
keyboard_arrow_right 2016
-
change-person-director-company-with-change-date (2016-05-12) - CH01
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2016-04-26) - AR01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2016-01-27) - AA
keyboard_arrow_right 2015
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2015-01-30) - AA
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2015-05-01) - AR01
keyboard_arrow_right 2014
-
capital-allotment-shares (2014-04-24) - SH01
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2014-04-24) - AR01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2014-01-03) - AA
keyboard_arrow_right 2013
-
appoint-person-director-company-with-name (2013-10-10) - AP01
-
appoint-person-director-company-with-name (2013-08-12) - AP01
-
termination-director-company-with-name (2013-08-10) - TM01
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2013-04-23) - AR01
keyboard_arrow_right 2012
-
incorporation-company (2012-04-03) - NEWINC
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address (2012-06-21) - AD01