-
JOYCE CLEANING SERVICES LTD - Livermore House, High Street, Dunmow, CM6 1AW, Grossbritannien
Firmenprofil
- Handelsregisternummer
- 08011278
- Firmenstatus
- EINGETRAGEN
- Land
- Grossbritannien
- Protokollierter Sitz
- Livermore House
- High Street
- Dunmow
- CM6 1AW
- England Livermore House, High Street, Dunmow, CM6 1AW, England UK
Management
- Geschäftsführung
- JOYCE, Charles Thomas
- KYBERT, Mark Anthony
- WALTERS, Keith Andrew
Firmendetails
- Geschäftszweig
- ltd
- Gründungsdatum
- 29.03.2012
- Alter der Firma 2012-03-29 12 Jahre
- SIC/NACE
- 81210
Eigentumsverhältnisse
- Beneficial Owners
- -
- Fiona Maureen Joyce
- Mr Keith Andrew Walters
- Mr Mark Anthony Kybert
- -
Landes-Besonderheiten
- Zusätzliche Statusdetails
- Active
- Bilanzhinterlegung
- Fälligkeit: 2024-06-30
- Letzte Einreichung: 2022-09-30
- lezte Bilanzhinterlegung
- 2013-03-29
- Jahresmeldung
- Fälligkeit: 2024-04-12
- Letzte Einreichung: 2023-03-29
-
JOYCE CLEANING SERVICES LTD Firmenbeschreibung
- JOYCE CLEANING SERVICES LTD ist eine in Grossbritannien als ltd registrierte Firma mit der Register-Nr. 08011278. Ihr derzeitiger Status ist "eingetragen". Die Firma wurde 29.03.2012 registriert. Das Unternehmen ist mit dem SIC/NACE Code "81210" registriert. Das Unternehmen hat 3 Geschäftsführer Die jährliche Meldung erfolgte zuletzt am 29.03.2013.Die Firma kann schriftlich über Livermore House erreicht werden.
Jetzt sichern JOYCE CLEANING SERVICES LTD HandelsregisterauszugJahresabschlussListe der GesellschafterGesellschaftsvertragBeneficial Owners Check
Sie befinden sich hier: Joyce Cleaning Services Ltd - Livermore House, High Street, Dunmow, CM6 1AW, Grossbritannien
- 2012-03-29
- 0-2
- 3-5
- 6-20
- 21-50
- 51+
- Jahre
Haben Sie gewusst? kompany stellt Ihnen amtliche & offizielle Dokumente zu JOYCE CLEANING SERVICES LTD aus Handelsregister und Firmenbuch im Original zur Verfügung. Das garantieren wir.
Handelsregisterauszug
Amtlicher Nachweis der Existenz des Unternehmens
Jahresabschluss
Finanzdaten zum letzten Berichtsjahr
Liste der Gesellschafter
Angaben zu den Eigentumsverhältnissen
Gesellschaftsvertrag
Gründungsdokumente
Beneficial Owners Check
Angaben über den wirtschaftlichen Eigentümer (Beneficial Owner)
Amtliche Dokumente
Amtliche Dokumente direkt vom offiziellen Handelsregister
keyboard_arrow_down 2023
-
gazette-filings-brought-up-to-date (2023-10-07) - DISS40
-
gazette-notice-compulsory (2023-06-20) - GAZ1
-
dissolved-compulsory-strike-off-suspended (2023-06-28) - DISS16(SOAS)
-
confirmation-statement-with-no-updates (2023-07-10) - CS01
-
gazette-filings-brought-up-to-date (2023-07-11) - DISS40
-
gazette-notice-compulsory (2023-09-05) - GAZ1
-
dissolved-compulsory-strike-off-suspended (2023-09-21) - DISS16(SOAS)
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2023-10-05) - AA
keyboard_arrow_right 2022
-
confirmation-statement-with-no-updates (2022-06-20) - CS01
-
gazette-notice-compulsory (2022-06-21) - GAZ1
-
gazette-filings-brought-up-to-date (2022-06-22) - DISS40
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2022-06-30) - AA
keyboard_arrow_right 2021
-
confirmation-statement-with-no-updates (2021-06-30) - CS01
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2021-06-30) - AD01
-
accounts-with-accounts-type-micro-entity (2021-06-30) - AA
keyboard_arrow_right 2020
-
change-to-a-person-with-significant-control (2020-04-16) - PSC04
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2020-04-16) - AA
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2020-03-26) - AA
-
change-person-director-company-with-change-date (2020-04-16) - CH01
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2020-05-14) - TM01
-
change-account-reference-date-company-previous-shortened (2020-04-16) - AA01
-
cessation-of-a-person-with-significant-control (2020-05-14) - PSC07
-
notification-of-a-person-with-significant-control (2020-05-14) - PSC01
-
confirmation-statement-with-updates (2020-05-14) - CS01
keyboard_arrow_right 2019
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2019-03-27) - AA
-
confirmation-statement-with-updates (2019-05-08) - CS01
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2019-10-08) - AP01
-
change-account-reference-date-company-previous-shortened (2019-12-26) - AA01
keyboard_arrow_right 2018
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2018-03-28) - AA
-
change-to-a-person-with-significant-control (2018-06-04) - PSC04
-
change-account-reference-date-company-previous-shortened (2018-12-27) - AA01
-
confirmation-statement-with-updates (2018-06-04) - CS01
keyboard_arrow_right 2017
-
change-account-reference-date-company-previous-shortened (2017-12-28) - AA01
-
confirmation-statement-with-updates (2017-04-06) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2017-03-29) - AA
keyboard_arrow_right 2016
-
change-account-reference-date-company-previous-shortened (2016-12-29) - AA01
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2016-04-20) - AR01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2016-03-30) - AA
keyboard_arrow_right 2015
-
change-account-reference-date-company-previous-shortened (2015-12-30) - AA01
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2015-06-11) - AR01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2015-03-30) - AA
keyboard_arrow_right 2014
-
change-account-reference-date-company-previous-shortened (2014-12-30) - AA01
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2014-05-01) - AR01
keyboard_arrow_right 2013
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2013-06-04) - AR01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2013-12-29) - AA
keyboard_arrow_right 2012
-
incorporation-company (2012-03-29) - NEWINC