-
CAERDAV LIMITED - Building 282 Scott Way, Bro Tathan West, St Athan, Vale Of Glamorgan, Grossbritannien
Firmenprofil
- Handelsregisternummer
- 08009507
- Firmenstatus
- EINGETRAGEN
- Land
- Grossbritannien
- Protokollierter Sitz
- Building 282 Scott Way
- Bro Tathan West
- St Athan
- Vale Of Glamorgan
- CF62 4AL
- Wales Building 282 Scott Way, Bro Tathan West, St Athan, Vale Of Glamorgan, CF62 4AL, Wales UK
Management
- Geschäftsführung
- DICKINSON, Bruce
- JONES, Joachim Stephen
- Prokuristen
- -
Firmendetails
- Geschäftszweig
- ltd
- Gründungsdatum
- 28.03.2012
- Alter der Firma 2012-03-28 12 Jahre
- SIC/NACE
- 52290
Eigentumsverhältnisse
- Beneficial Owners
- Mr Paul Bruce Dickinson
- Cardiff Operating Group Limited
Landes-Besonderheiten
- Zusätzliche Statusdetails
- active
- Ehemalige Namen
- CARDIFF AVIATION LIMITED
- Bilanzhinterlegung
- Fälligkeit: 2021-06-30
- Letzte Einreichung: 2019-09-30
- Jahresmeldung
- Fälligkeit: 2021-09-05
- Letzte Einreichung: 2020-08-22
-
CAERDAV LIMITED Firmenbeschreibung
- CAERDAV LIMITED ist eine in Grossbritannien als ltd registrierte Firma mit der Register-Nr. 08009507. Ihr derzeitiger Status ist "eingetragen". Die Firma wurde 28.03.2012 registriert. CAERDAV LIMITED hat Ihre Tätigkeit zuvor unter dem Namen CARDIFF AVIATION LIMITED ausgeführt. Das Unternehmen ist mit dem SIC/NACE Code "52290" registriert. Das Unternehmen hat 2 Geschäftsführer Die Firma kann schriftlich über Building 282 Scott Way erreicht werden.
Jetzt sichern CAERDAV LIMITED HandelsregisterauszugJahresabschlussListe der GesellschafterGesellschaftsvertragBeneficial Owners Check
Sie befinden sich hier: Caerdav Limited - Building 282 Scott Way, Bro Tathan West, St Athan, Vale Of Glamorgan, Grossbritannien
- 2012-03-28
- 0-2
- 3-5
- 6-20
- 21-50
- 51+
- Jahre
Haben Sie gewusst? kompany stellt Ihnen amtliche & offizielle Dokumente zu CAERDAV LIMITED aus Handelsregister und Firmenbuch im Original zur Verfügung. Das garantieren wir.
Handelsregisterauszug
Amtlicher Nachweis der Existenz des Unternehmens
Jahresabschluss
Finanzdaten zum letzten Berichtsjahr
Liste der Gesellschafter
Angaben zu den Eigentumsverhältnissen
Gesellschaftsvertrag
Gründungsdokumente
Beneficial Owners Check
Angaben über den wirtschaftlichen Eigentümer (Beneficial Owner)
Amtliche Dokumente
Amtliche Dokumente direkt vom offiziellen Handelsregister
keyboard_arrow_down 2020
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2020-09-01) - AD01
-
confirmation-statement-with-no-updates (2020-10-14) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2020-07-09) - AA
keyboard_arrow_right 2019
-
notification-of-a-person-with-significant-control (2019-08-22) - PSC02
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2019-07-02) - AA
-
resolution (2019-06-06) - RESOLUTIONS
-
resolution (2019-05-01) - RESOLUTIONS
-
mortgage-create-with-deed-with-charge-number-charge-creation-date (2019-04-17) - MR01
-
confirmation-statement-with-no-updates (2019-02-25) - CS01
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2019-02-15) - AP01
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2019-02-15) - TM01
-
confirmation-statement-with-updates (2019-08-22) - CS01
keyboard_arrow_right 2018
-
confirmation-statement-with-no-updates (2018-02-21) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2018-07-06) - AA
keyboard_arrow_right 2017
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2017-06-21) - AA
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2017-06-05) - TM01
-
termination-secretary-company-with-name-termination-date (2017-06-01) - TM02
-
gazette-filings-brought-up-to-date (2017-04-26) - DISS40
-
confirmation-statement-with-updates (2017-04-25) - CS01
-
gazette-notice-compulsory (2017-04-25) - GAZ1
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2017-02-17) - AP01
keyboard_arrow_right 2016
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2016-03-16) - AR01
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2016-01-06) - TM01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2016-06-30) - AA
keyboard_arrow_right 2015
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2015-12-24) - TM01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2015-07-04) - AA
-
change-account-reference-date-company-previous-extended (2015-02-20) - AA01
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2015-02-10) - AR01
keyboard_arrow_right 2014
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2014-10-24) - AP01
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2014-10-22) - AP01
-
resolution (2014-10-21) - RESOLUTIONS
-
termination-director-company-with-name (2014-06-24) - TM01
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2014-04-23) - AR01
keyboard_arrow_right 2013
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2013-04-24) - AR01
-
mortgage-create-with-deed-with-charge-number (2013-05-31) - MR01
-
resolution (2013-06-13) - RESOLUTIONS
-
capital-alter-shares-subdivision (2013-06-13) - SH02
-
change-account-reference-date-company-previous-extended (2013-11-13) - AA01
-
appoint-person-director-company-with-name (2013-06-20) - AP01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2013-12-23) - AA
-
capital-allotment-shares (2013-06-13) - SH01
keyboard_arrow_right 2012
-
incorporation-company (2012-03-28) - NEWINC
-
appoint-person-secretary-company-with-name (2012-10-08) - AP03
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address (2012-10-08) - AD01
-
appoint-person-director-company-with-name (2012-08-07) - AP01