-
VISION FIBRE MEDIA LTD - C/O Uhy Hacker Young St James Building, 79 Oxford Street, Manchester, Lancashire, Grossbritannien
Firmenprofil
- Handelsregisternummer
- 08003317
- Firmenstatus
- EINGETRAGEN
- Land
- Grossbritannien
- Protokollierter Sitz
- C/O Uhy Hacker Young St James Building
- 79 Oxford Street
- Manchester
- Lancashire
- M1 6HT
- England C/O Uhy Hacker Young St James Building, 79 Oxford Street, Manchester, Lancashire, M1 6HT, England UK
Management
- Geschäftsführung
- BEAMISH, Nicola Jayne
- HUGHES, Anthony Stephen
Firmendetails
- Geschäftszweig
- ltd
- Gründungsdatum
- 23.03.2012
- Alter der Firma 2012-03-23 12 Jahre
- SIC/NACE
- 61900
Eigentumsverhältnisse
- Beneficial Owners
- Mrs Sharon Ratcliffe
- -
- Liberatis Limited
- -
- -
Landes-Besonderheiten
- Zusätzliche Statusdetails
- active
- Bilanzhinterlegung
- Fälligkeit: 2022-12-31
- Letzte Einreichung: 2021-03-31
- Jahresmeldung
- Fälligkeit: 2022-02-20
- Letzte Einreichung: 2021-02-06
-
VISION FIBRE MEDIA LTD Firmenbeschreibung
- VISION FIBRE MEDIA LTD ist eine in Grossbritannien als ltd registrierte Firma mit der Register-Nr. 08003317. Ihr derzeitiger Status ist "eingetragen". Die Firma wurde 23.03.2012 registriert. Das Unternehmen ist mit dem SIC/NACE Code "61900" registriert. Das Unternehmen hat 2 Geschäftsführer Die Firma kann schriftlich über C/o Uhy Hacker Young St James Building erreicht werden.
Jetzt sichern VISION FIBRE MEDIA LTD HandelsregisterauszugJahresabschlussListe der GesellschafterGesellschaftsvertragBeneficial Owners Check
Sie befinden sich hier: Vision Fibre Media Ltd - C/O Uhy Hacker Young St James Building, 79 Oxford Street, Manchester, Lancashire, Grossbritannien
- 2012-03-23
- 0-2
- 3-5
- 6-20
- 21-50
- 51+
- Jahre
Haben Sie gewusst? kompany stellt Ihnen amtliche & offizielle Dokumente zu VISION FIBRE MEDIA LTD aus Handelsregister und Firmenbuch im Original zur Verfügung. Das garantieren wir.
Handelsregisterauszug
Amtlicher Nachweis der Existenz des Unternehmens
Jahresabschluss
Finanzdaten zum letzten Berichtsjahr
Liste der Gesellschafter
Angaben zu den Eigentumsverhältnissen
Gesellschaftsvertrag
Gründungsdokumente
Beneficial Owners Check
Angaben über den wirtschaftlichen Eigentümer (Beneficial Owner)
Amtliche Dokumente
Amtliche Dokumente direkt vom offiziellen Handelsregister
keyboard_arrow_down 2021
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2021-10-14) - AA
-
cessation-of-a-person-with-significant-control (2021-03-02) - PSC07
-
notification-of-a-person-with-significant-control (2021-03-02) - PSC02
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2021-03-02) - TM01
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2021-03-02) - AP01
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2021-03-02) - AD01
-
change-to-a-person-with-significant-control (2021-01-14) - PSC04
-
confirmation-statement-with-no-updates (2021-03-09) - CS01
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2021-04-20) - TM01
keyboard_arrow_right 2020
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2020-08-13) - AA
-
confirmation-statement-with-no-updates (2020-02-06) - CS01
keyboard_arrow_right 2019
-
confirmation-statement-with-updates (2019-03-28) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2019-11-01) - AA
-
cessation-of-a-person-with-significant-control (2019-03-28) - PSC07
-
capital-return-purchase-own-shares (2019-01-28) - SH03
-
capital-cancellation-shares (2019-01-18) - SH06
keyboard_arrow_right 2018
-
notification-of-a-person-with-significant-control (2018-09-04) - PSC01
-
confirmation-statement-with-no-updates (2018-03-27) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2018-07-21) - AA
keyboard_arrow_right 2017
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2017-10-09) - AA
-
confirmation-statement-with-updates (2017-04-06) - CS01
keyboard_arrow_right 2016
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2016-09-28) - AA
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2016-08-17) - AP01
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2016-05-04) - AR01
keyboard_arrow_right 2015
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2015-03-30) - AR01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2015-12-03) - AA
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2015-12-22) - AD01
keyboard_arrow_right 2014
-
capital-allotment-shares (2014-12-30) - SH01
-
capital-allotment-shares (2014-03-11) - SH01
-
appoint-person-director-company-with-name (2014-03-11) - AP01
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2014-04-02) - AR01
-
capital-name-of-class-of-shares (2014-12-30) - SH08
-
capital-variation-of-rights-attached-to-shares (2014-12-30) - SH10
-
resolution (2014-12-30) - RESOLUTIONS
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2014-12-12) - AA
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2014-12-30) - TM01
keyboard_arrow_right 2013
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2013-12-06) - AA
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2013-04-10) - AR01
keyboard_arrow_right 2012
-
incorporation-company (2012-03-23) - NEWINC