-
SPOREGEN LIMITED - The London Bioscience Innovation Centre, 2 Royal College Street, London, NW1 0NH, Grossbritannien
Firmenprofil
- Handelsregisternummer
- 08001035
- Firmenstatus
- EINGETRAGEN
- Land
- Grossbritannien
- Protokollierter Sitz
- The London Bioscience Innovation Centre
- 2 Royal College Street
- London
- NW1 0NH
- England The London Bioscience Innovation Centre, 2 Royal College Street, London, NW1 0NH, England UK
Management
- Geschäftsführung
- CUTTING, Simon Michael, Dr
- Prokuristen
- -
Firmendetails
- Geschäftszweig
- ltd
- Gründungsdatum
- 22.03.2012
- Alter der Firma 2012-03-22 12 Jahre
- SIC/NACE
- 72110
Eigentumsverhältnisse
- Beneficial Owners
- Mr Simon Michael Cutting
- Dr Simon Michael Cutting
Landes-Besonderheiten
- Zusätzliche Statusdetails
- active
- Ehemalige Namen
- HOLLOWAY IMMUNOLOGY LTD
- Bilanzhinterlegung
- Fälligkeit: 2021-12-31
- Letzte Einreichung: 2020-03-31
- Jahresmeldung
- Fälligkeit: 2022-04-05
- Letzte Einreichung: 2021-03-22
-
SPOREGEN LIMITED Firmenbeschreibung
- SPOREGEN LIMITED ist eine in Grossbritannien als ltd registrierte Firma mit der Register-Nr. 08001035. Ihr derzeitiger Status ist "eingetragen". Die Firma wurde 22.03.2012 registriert. SPOREGEN LIMITED hat Ihre Tätigkeit zuvor unter dem Namen HOLLOWAY IMMUNOLOGY LTD ausgeführt. Das Unternehmen ist mit dem SIC/NACE Code "72110" registriert. Das Unternehmen hat 1 Geschäftsführer Die Firma kann schriftlich über The London Bioscience Innovation Centre erreicht werden.
Jetzt sichern SPOREGEN LIMITED HandelsregisterauszugJahresabschlussListe der GesellschafterGesellschaftsvertragBeneficial Owners Check
Sie befinden sich hier: Sporegen Limited - The London Bioscience Innovation Centre, 2 Royal College Street, London, NW1 0NH, Grossbritannien
- 2012-03-22
- 0-2
- 3-5
- 6-20
- 21-50
- 51+
- Jahre
Haben Sie gewusst? kompany stellt Ihnen amtliche & offizielle Dokumente zu SPOREGEN LIMITED aus Handelsregister und Firmenbuch im Original zur Verfügung. Das garantieren wir.
Handelsregisterauszug
Amtlicher Nachweis der Existenz des Unternehmens
Jahresabschluss
Finanzdaten zum letzten Berichtsjahr
Liste der Gesellschafter
Angaben zu den Eigentumsverhältnissen
Gesellschaftsvertrag
Gründungsdokumente
Beneficial Owners Check
Angaben über den wirtschaftlichen Eigentümer (Beneficial Owner)
Amtliche Dokumente
Amtliche Dokumente direkt vom offiziellen Handelsregister
keyboard_arrow_down 2021
-
resolution (2021-11-23) - RESOLUTIONS
-
confirmation-statement-with-updates (2021-03-23) - CS01
keyboard_arrow_right 2020
-
confirmation-statement-with-no-updates (2020-03-23) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2020-08-19) - AA
keyboard_arrow_right 2019
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2019-11-04) - AD01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2019-10-18) - AA
-
confirmation-statement-with-no-updates (2019-03-28) - CS01
-
change-to-a-person-with-significant-control (2019-03-26) - PSC04
keyboard_arrow_right 2018
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2018-01-03) - AA
-
confirmation-statement-with-updates (2018-03-29) - CS01
-
resolution (2018-03-27) - RESOLUTIONS
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2018-04-24) - AD01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2018-10-17) - AA
-
termination-secretary-company-with-name-termination-date (2018-04-24) - TM02
keyboard_arrow_right 2017
-
change-person-director-company-with-change-date (2017-09-08) - CH01
-
change-corporate-secretary-company-with-change-date (2017-09-08) - CH04
-
confirmation-statement-with-updates (2017-03-24) - CS01
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2017-01-24) - TM01
keyboard_arrow_right 2016
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2016-02-18) - AD01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2016-12-08) - AA
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2016-05-24) - AR01
keyboard_arrow_right 2015
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2015-12-06) - AA
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2015-04-14) - AR01
keyboard_arrow_right 2014
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2014-12-31) - AA
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2014-08-05) - AP01
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2014-04-14) - AR01
-
change-person-director-company-with-change-date (2014-04-14) - CH01
keyboard_arrow_right 2013
-
termination-director-company-with-name (2013-03-20) - TM01
-
appoint-person-director-company-with-name (2013-03-21) - AP01
-
change-person-director-company-with-change-date (2013-04-17) - CH01
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2013-04-17) - AR01
-
resolution (2013-07-05) - RESOLUTIONS
-
legacy (2013-07-05) - CAP-SS
-
legacy (2013-07-05) - SH20
-
appoint-person-director-company-with-name (2013-11-29) - AP01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2013-12-11) - AA
-
capital-allotment-shares (2013-12-18) - SH01
-
certificate-change-of-name-company (2013-12-19) - CERTNM
-
capital-statement-capital-company-with-date-currency-figure (2013-07-18) - SH19
keyboard_arrow_right 2012
-
resolution (2012-09-17) - RESOLUTIONS
-
capital-allotment-shares (2012-08-07) - SH01
-
capital-allotment-shares (2012-05-01) - SH01
-
incorporation-company (2012-03-22) - NEWINC