-
MONEY ADVICE CONSULTANCY LTD - Sandfold House, Sandfold Lane, Manchester, M19 3BJ, Grossbritannien
Firmenprofil
- Handelsregisternummer
- 08000969
- Firmenstatus
- GELÖSCHT
- Land
- Grossbritannien
- Protokollierter Sitz
- Sandfold House
- Sandfold Lane
- Manchester
- M19 3BJ
- England Sandfold House, Sandfold Lane, Manchester, M19 3BJ, England UK
Management
- Geschäftsführung
- FLYNN, Breandan Sean Manning
Firmendetails
- Geschäftszweig
- ltd
- Gründungsdatum
- 22.03.2012
- Gelöscht am:
- 2021-09-11
- SIC/NACE
- 66190
Eigentumsverhältnisse
- Beneficial Owners
- Mr Michael Paterson
- Mr Breandan Flynn
- -
Landes-Besonderheiten
- Zusätzliche Statusdetails
- dissolved
- Ehemalige Namen
- MP INSOLVENCY LIMITED
- Bilanzhinterlegung
- Fälligkeit: 2020-03-31
- Letzte Einreichung: 2018-06-30
- Jahresmeldung
- Fälligkeit: 2021-03-15
- Letzte Einreichung: 2020-03-01
-
MONEY ADVICE CONSULTANCY LTD Firmenbeschreibung
- MONEY ADVICE CONSULTANCY LTD ist eine in Grossbritannien als ltd registrierte Firma mit der Register-Nr. 08000969. Ihr derzeitiger Status ist "gelöscht". Die Firma wurde 22.03.2012 registriert. MONEY ADVICE CONSULTANCY LTD hat Ihre Tätigkeit zuvor unter dem Namen MP INSOLVENCY LIMITED ausgeführt. Das Unternehmen ist mit dem SIC/NACE Code "66190" registriert. Das Unternehmen hat 1 Geschäftsführer Die Firma kann schriftlich über Sandfold House erreicht werden.
Jetzt sichern MONEY ADVICE CONSULTANCY LTD HandelsregisterauszugJahresabschlussListe der GesellschafterGesellschaftsvertragBeneficial Owners Check
Sie befinden sich hier: Money Advice Consultancy Ltd - Sandfold House, Sandfold Lane, Manchester, M19 3BJ, Grossbritannien
Haben Sie gewusst? kompany stellt Ihnen amtliche & offizielle Dokumente zu MONEY ADVICE CONSULTANCY LTD aus Handelsregister und Firmenbuch im Original zur Verfügung. Das garantieren wir.
Handelsregisterauszug
Amtlicher Nachweis der Existenz des Unternehmens
Jahresabschluss
Finanzdaten zum letzten Berichtsjahr
Liste der Gesellschafter
Angaben zu den Eigentumsverhältnissen
Gesellschaftsvertrag
Gründungsdokumente
Beneficial Owners Check
Angaben über den wirtschaftlichen Eigentümer (Beneficial Owner)
Amtliche Dokumente
Amtliche Dokumente direkt vom offiziellen Handelsregister
keyboard_arrow_down 2020
-
confirmation-statement-with-updates (2020-03-30) - CS01
-
notification-of-a-person-with-significant-control (2020-03-11) - PSC01
-
cessation-of-a-person-with-significant-control (2020-03-11) - PSC07
-
resolution (2020-04-30) - RESOLUTIONS
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2020-03-11) - TM01
-
liquidation-voluntary-appointment-of-liquidator (2020-04-30) - 600
-
liquidation-voluntary-statement-of-affairs (2020-04-30) - LIQ02
keyboard_arrow_right 2019
-
confirmation-statement-with-no-updates (2019-12-05) - CS01
-
resolution (2019-09-05) - RESOLUTIONS
-
resolution (2019-03-19) - RESOLUTIONS
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2019-02-25) - AD01
keyboard_arrow_right 2018
-
change-to-a-person-with-significant-control (2018-11-14) - PSC04
-
confirmation-statement-with-updates (2018-12-17) - CS01
-
capital-allotment-shares (2018-12-03) - SH01
-
change-person-director-company-with-change-date (2018-11-14) - CH01
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2018-10-31) - AP01
-
accounts-with-accounts-type-micro-entity (2018-09-17) - AA
-
accounts-with-accounts-type-micro-entity (2018-03-31) - AA
keyboard_arrow_right 2017
-
confirmation-statement-with-updates (2017-02-21) - CS01
-
confirmation-statement-with-no-updates (2017-12-15) - CS01
-
mortgage-satisfy-charge-full (2017-02-17) - MR04
-
change-person-director-company-with-change-date (2017-02-21) - CH01
-
change-account-reference-date-company-previous-extended (2017-12-18) - AA01
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2017-02-21) - AD01
keyboard_arrow_right 2016
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2016-07-08) - TM01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2016-12-23) - AA
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2016-07-08) - AP01
keyboard_arrow_right 2015
-
gazette-notice-compulsory (2015-03-17) - GAZ1
-
dissolved-compulsory-strike-off-suspended (2015-05-08) - DISS16(SOAS)
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2015-06-08) - AP01
-
certificate-change-of-name-company (2015-06-10) - CERTNM
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2015-06-16) - AD01
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2015-06-08) - TM01
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2015-11-30) - AD01
-
gazette-filings-brought-up-to-date (2015-12-01) - DISS40
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2015-12-03) - AR01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2015-12-22) - AA
-
accounts-with-accounts-type-dormant (2015-11-28) - AA
keyboard_arrow_right 2014
-
dissolved-compulsory-strike-off-suspended (2014-08-29) - DISS16(SOAS)
-
gazette-notice-compulsary (2014-07-22) - GAZ1
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2014-02-10) - AA
keyboard_arrow_right 2013
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2013-05-21) - AR01
keyboard_arrow_right 2012
-
incorporation-company (2012-03-22) - NEWINC
-
legacy (2012-06-29) - MG01