-
CAB POWDER COATING LTD - 6th Floor Bank House, 8 Cherry Street, Birmingham, B2 5AL, Grossbritannien
Firmenprofil
- Handelsregisternummer
- 07989152
- Firmenstatus
- GELÖSCHT
- Land
- Grossbritannien
- Protokollierter Sitz
- 6th Floor Bank House
- 8 Cherry Street
- Birmingham
- B2 5AL 6th Floor Bank House, 8 Cherry Street, Birmingham, B2 5AL UK
Management
- Geschäftsführung
- MILES, Brian Charles
- Prokuristen
- -
Firmendetails
- Geschäftszweig
- ltd
- Gründungsdatum
- 13.03.2012
- Gelöscht am:
- 2021-09-01
- SIC/NACE
- 25610
Eigentumsverhältnisse
- Beneficial Owners
- Cabauto Group Limited
Landes-Besonderheiten
- Zusätzliche Statusdetails
- dissolved
- Bilanzhinterlegung
- Fälligkeit: 2019-09-30
- Letzte Einreichung: 2017-12-31
- Jahresmeldung
- Fälligkeit: 2020-03-27
- Letzte Einreichung: 2019-03-13
-
CAB POWDER COATING LTD Firmenbeschreibung
- CAB POWDER COATING LTD ist eine in Grossbritannien als ltd registrierte Firma mit der Register-Nr. 07989152. Ihr derzeitiger Status ist "gelöscht". Die Firma wurde 13.03.2012 registriert. Das Unternehmen ist mit dem SIC/NACE Code "25610" registriert. Das Unternehmen hat 1 Geschäftsführer Die Firma kann schriftlich über 6Th Floor Bank House erreicht werden.
Jetzt sichern CAB POWDER COATING LTD HandelsregisterauszugJahresabschlussListe der GesellschafterGesellschaftsvertragBeneficial Owners Check
Sie befinden sich hier: Cab Powder Coating Ltd - 6th Floor Bank House, 8 Cherry Street, Birmingham, B2 5AL, Grossbritannien
Haben Sie gewusst? kompany stellt Ihnen amtliche & offizielle Dokumente zu CAB POWDER COATING LTD aus Handelsregister und Firmenbuch im Original zur Verfügung. Das garantieren wir.
Handelsregisterauszug
Amtlicher Nachweis der Existenz des Unternehmens
Jahresabschluss
Finanzdaten zum letzten Berichtsjahr
Liste der Gesellschafter
Angaben zu den Eigentumsverhältnissen
Gesellschaftsvertrag
Gründungsdokumente
Beneficial Owners Check
Angaben über den wirtschaftlichen Eigentümer (Beneficial Owner)
Amtliche Dokumente
Amtliche Dokumente direkt vom offiziellen Handelsregister
keyboard_arrow_down 2020
-
liquidation-voluntary-statement-of-receipts-and-payments-with-brought-down-date (2020-10-02) - LIQ03
keyboard_arrow_right 2019
-
liquidation-voluntary-statement-of-affairs (2019-09-07) - LIQ02
-
liquidation-voluntary-appointment-of-liquidator (2019-09-07) - 600
-
resolution (2019-09-07) - RESOLUTIONS
-
confirmation-statement-with-updates (2019-03-15) - CS01
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2019-09-10) - AD01
keyboard_arrow_right 2018
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2018-09-28) - AA
-
confirmation-statement-with-updates (2018-03-19) - CS01
keyboard_arrow_right 2017
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2017-10-02) - AA
-
mortgage-satisfy-charge-full (2017-09-26) - MR04
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2017-06-28) - AD01
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2017-06-13) - TM01
-
termination-secretary-company-with-name-termination-date (2017-06-13) - TM02
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2017-04-24) - TM01
-
confirmation-statement-with-updates (2017-03-14) - CS01
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2017-03-01) - AP01
keyboard_arrow_right 2016
-
accounts-with-accounts-type-full (2016-10-06) - AA
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2016-03-14) - AR01
keyboard_arrow_right 2015
-
accounts-with-accounts-type-small (2015-10-13) - AA
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2015-03-16) - AR01
keyboard_arrow_right 2014
-
accounts-with-accounts-type-dormant (2014-09-17) - AA
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2014-05-27) - AR01
keyboard_arrow_right 2013
-
accounts-with-accounts-type-dormant (2013-12-05) - AA
-
change-account-reference-date-company-previous-shortened (2013-11-28) - AA01
-
mortgage-create-with-deed-with-charge-number (2013-11-01) - MR01
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2013-06-18) - AR01
keyboard_arrow_right 2012
-
termination-director-company-with-name (2012-04-12) - TM01
-
incorporation-company (2012-03-13) - NEWINC