-
JORDANS SOLICITORS MIDLANDS LIMITED - 35 Payne Street, Blackheath, West Midlands, B65 0DH, Grossbritannien
Firmenprofil
- Handelsregisternummer
- 07983073
- Firmenstatus
- EINGETRAGEN
- Land
- Grossbritannien
- Protokollierter Sitz
- 35 Payne Street
- Blackheath
- West Midlands
- B65 0DH 35 Payne Street, Blackheath, West Midlands, B65 0DH UK
Management
- Geschäftsführung
- JORDAN, Michael James
- KOONER, Baldeep Kaur
- BATEMAN, Rikki Lee
- Prokuristen
- JORDAN, John Craig
Firmendetails
- Geschäftszweig
- ltd
- Gründungsdatum
- 09.03.2012
- Alter der Firma 2012-03-09 12 Jahre
- SIC/NACE
- 69102
Eigentumsverhältnisse
- Beneficial Owners
- -
- Jordans Midlands Holdings Limited
Landes-Besonderheiten
- Zusätzliche Statusdetails
- Active
- Bilanzhinterlegung
- Fälligkeit: 2023-12-31
- Letzte Einreichung: 2022-03-31
- Jahresmeldung
- Fälligkeit: 2024-03-23
- Letzte Einreichung: 2023-03-09
-
JORDANS SOLICITORS MIDLANDS LIMITED Firmenbeschreibung
- JORDANS SOLICITORS MIDLANDS LIMITED ist eine in Grossbritannien als ltd registrierte Firma mit der Register-Nr. 07983073. Ihr derzeitiger Status ist "eingetragen". Die Firma wurde 09.03.2012 registriert. Das Unternehmen ist mit dem SIC/NACE Code "69102" registriert. Das Unternehmen hat 3 Geschäftsführer und 1 Prokuristen.Die Firma kann schriftlich über 35 Payne Street erreicht werden.
Jetzt sichern JORDANS SOLICITORS MIDLANDS LIMITED HandelsregisterauszugJahresabschlussListe der GesellschafterGesellschaftsvertragBeneficial Owners Check
Sie befinden sich hier: Jordans Solicitors Midlands Limited - 35 Payne Street, Blackheath, West Midlands, B65 0DH, Grossbritannien
- 2012-03-09
- 0-2
- 3-5
- 6-20
- 21-50
- 51+
- Jahre
Haben Sie gewusst? kompany stellt Ihnen amtliche & offizielle Dokumente zu JORDANS SOLICITORS MIDLANDS LIMITED aus Handelsregister und Firmenbuch im Original zur Verfügung. Das garantieren wir.
Handelsregisterauszug
Amtlicher Nachweis der Existenz des Unternehmens
Jahresabschluss
Finanzdaten zum letzten Berichtsjahr
Liste der Gesellschafter
Angaben zu den Eigentumsverhältnissen
Gesellschaftsvertrag
Gründungsdokumente
Beneficial Owners Check
Angaben über den wirtschaftlichen Eigentümer (Beneficial Owner)
Amtliche Dokumente
Amtliche Dokumente direkt vom offiziellen Handelsregister
keyboard_arrow_down 2023
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2023-02-08) - TM01
-
confirmation-statement-with-no-updates (2023-03-21) - CS01
-
mortgage-satisfy-charge-full (2023-04-25) - MR04
keyboard_arrow_right 2022
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2022-02-14) - TM01
-
capital-cancellation-shares (2022-02-14) - SH06
-
confirmation-statement-with-updates (2022-03-23) - CS01
-
cessation-of-a-person-with-significant-control (2022-04-25) - PSC07
-
notification-of-a-person-with-significant-control (2022-04-25) - PSC02
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2022-05-03) - AP01
-
capital-return-purchase-own-shares (2022-05-18) - SH03
-
resolution (2022-05-19) - RESOLUTIONS
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2022-08-16) - AA
keyboard_arrow_right 2021
-
confirmation-statement-with-no-updates (2021-03-16) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2021-12-21) - AA
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2021-05-10) - AA
keyboard_arrow_right 2020
-
confirmation-statement-with-no-updates (2020-04-07) - CS01
-
change-person-director-company-with-change-date (2020-04-07) - CH01
-
change-to-a-person-with-significant-control (2020-04-07) - PSC04
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2020-01-02) - AA
keyboard_arrow_right 2019
-
confirmation-statement-with-updates (2019-03-11) - CS01
keyboard_arrow_right 2018
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2018-08-29) - AA
-
confirmation-statement-with-updates (2018-04-03) - CS01
keyboard_arrow_right 2017
-
confirmation-statement-with-updates (2017-03-10) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2017-09-08) - AA
keyboard_arrow_right 2016
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2016-09-23) - AA
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2016-03-09) - AR01
keyboard_arrow_right 2015
-
resolution (2015-01-22) - RESOLUTIONS
-
capital-name-of-class-of-shares (2015-01-22) - SH08
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2015-12-15) - AA
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2015-03-11) - AR01
-
mortgage-create-with-deed-with-charge-number-charge-creation-date (2015-03-05) - MR01
keyboard_arrow_right 2014
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2014-03-11) - AR01
-
change-person-director-company-with-change-date (2014-03-10) - CH01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2014-07-29) - AA
keyboard_arrow_right 2013
-
resolution (2013-12-11) - RESOLUTIONS
-
capital-variation-of-rights-attached-to-shares (2013-12-11) - SH10
-
memorandum-articles (2013-12-11) - MEM/ARTS
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2013-12-10) - AA
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2013-04-17) - AR01
-
change-person-director-company-with-change-date (2013-03-04) - CH01
keyboard_arrow_right 2012
-
incorporation-company (2012-03-09) - NEWINC
-
resolution (2012-03-19) - RESOLUTIONS
-
legacy (2012-05-31) - MG01