-
ADVANTAGE AUTOMOTIVE LIMITED - Unit 14 Presteigne Industrial Estate, Presteigne, LD8 2UF, Wales, Grossbritannien
Firmenprofil
- Handelsregisternummer
- 07981550
- Firmenstatus
- EINGETRAGEN
- Land
- Grossbritannien
- Protokollierter Sitz
- Unit 14 Presteigne Industrial Estate
- Presteigne
- LD8 2UF
- Wales Unit 14 Presteigne Industrial Estate, Presteigne, LD8 2UF, Wales UK
Management
- Geschäftsführung
- JONES, Michael Russell
Firmendetails
- Geschäftszweig
- ltd
- Gründungsdatum
- 08.03.2012
- Alter der Firma 2012-03-08 12 Jahre
- SIC/NACE
- 82990
Eigentumsverhältnisse
- Beneficial Owners
- Mr Michael Russell Jones
- -
Landes-Besonderheiten
- Zusätzliche Statusdetails
- active
- Ehemalige Namen
- HADLEY HARGREAVES (REDDITCH) LIMITED
- Bilanzhinterlegung
- Fälligkeit: 2021-12-31
- Letzte Einreichung: 2020-03-31
- lezte Bilanzhinterlegung
- 2013-03-08
- Jahresmeldung
- Fälligkeit: 2022-03-22
- Letzte Einreichung: 2021-03-08
-
ADVANTAGE AUTOMOTIVE LIMITED Firmenbeschreibung
- ADVANTAGE AUTOMOTIVE LIMITED ist eine in Grossbritannien als ltd registrierte Firma mit der Register-Nr. 07981550. Ihr derzeitiger Status ist "eingetragen". Die Firma wurde 08.03.2012 registriert. ADVANTAGE AUTOMOTIVE LIMITED hat Ihre Tätigkeit zuvor unter dem Namen HADLEY HARGREAVES (REDDITCH) LIMITED ausgeführt. Das Unternehmen ist mit dem SIC/NACE Code "82990" registriert. Das Unternehmen hat 1 Geschäftsführer Die jährliche Meldung erfolgte zuletzt am 08.03.2013.Die Firma kann schriftlich über Unit 14 Presteigne Industrial Estate erreicht werden.
Jetzt sichern ADVANTAGE AUTOMOTIVE LIMITED HandelsregisterauszugJahresabschlussListe der GesellschafterGesellschaftsvertragBeneficial Owners Check
Sie befinden sich hier: Advantage Automotive Limited - Unit 14 Presteigne Industrial Estate, Presteigne, LD8 2UF, Wales, Grossbritannien
- 2012-03-08
- 0-2
- 3-5
- 6-20
- 21-50
- 51+
- Jahre
Haben Sie gewusst? kompany stellt Ihnen amtliche & offizielle Dokumente zu ADVANTAGE AUTOMOTIVE LIMITED aus Handelsregister und Firmenbuch im Original zur Verfügung. Das garantieren wir.
Handelsregisterauszug
Amtlicher Nachweis der Existenz des Unternehmens
Jahresabschluss
Finanzdaten zum letzten Berichtsjahr
Liste der Gesellschafter
Angaben zu den Eigentumsverhältnissen
Gesellschaftsvertrag
Gründungsdokumente
Beneficial Owners Check
Angaben über den wirtschaftlichen Eigentümer (Beneficial Owner)
Amtliche Dokumente
Amtliche Dokumente direkt vom offiziellen Handelsregister
keyboard_arrow_down 2021
-
change-to-a-person-with-significant-control (2021-03-09) - PSC04
-
confirmation-statement-with-updates (2021-03-09) - CS01
keyboard_arrow_right 2020
-
change-person-director-company-with-change-date (2020-11-26) - CH01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2020-10-20) - AA
-
confirmation-statement-with-updates (2020-04-03) - CS01
-
change-to-a-person-with-significant-control (2020-11-26) - PSC04
keyboard_arrow_right 2019
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2019-12-23) - AA
-
change-to-a-person-with-significant-control (2019-10-21) - PSC04
-
change-person-director-company-with-change-date (2019-10-21) - CH01
-
cessation-of-a-person-with-significant-control (2019-04-26) - PSC07
-
confirmation-statement-with-no-updates (2019-03-15) - CS01
keyboard_arrow_right 2018
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2018-01-24) - AD01
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2018-01-24) - TM01
-
gazette-notice-compulsory (2018-03-06) - GAZ1
-
confirmation-statement-with-no-updates (2018-04-09) - CS01
-
gazette-filings-brought-up-to-date (2018-03-31) - DISS40
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2018-03-29) - AA
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2018-12-30) - AA
keyboard_arrow_right 2017
-
confirmation-statement-with-updates (2017-04-28) - CS01
-
mortgage-satisfy-charge-full (2017-04-18) - MR04
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2017-01-11) - AA
keyboard_arrow_right 2016
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2016-03-08) - AR01
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2016-03-08) - AD01
-
mortgage-create-with-deed-with-charge-number-charge-creation-date (2016-02-08) - MR01
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2016-01-12) - AD01
keyboard_arrow_right 2015
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2015-12-18) - AA
-
resolution (2015-06-02) - RESOLUTIONS
-
capital-name-of-class-of-shares (2015-06-02) - SH08
-
capital-allotment-shares (2015-06-02) - SH01
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2015-06-10) - AP01
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2015-03-10) - AR01
-
change-person-director-company-with-change-date (2015-11-04) - CH01
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2015-11-11) - AD01
-
change-person-director-company-with-change-date (2015-11-11) - CH01
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2015-10-28) - AD01
keyboard_arrow_right 2014
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2014-10-20) - AA
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2014-05-27) - AR01
keyboard_arrow_right 2013
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address (2013-12-11) - AD01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2013-12-11) - AA
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2013-04-02) - AR01
keyboard_arrow_right 2012
-
legacy (2012-10-17) - MG01
-
certificate-change-of-name-company (2012-05-02) - CERTNM
-
change-of-name-notice (2012-05-02) - CONNOT
-
capital-allotment-shares (2012-05-01) - SH01
-
incorporation-company (2012-03-08) - NEWINC