-
MRA REAL ESTATE LIMITED - Alexander House Highfield Park, Llandyrnog, Denbighshire, LL16 4LU, Grossbritannien
Firmenprofil
- Handelsregisternummer
- 07975202
- Firmenstatus
- EINGETRAGEN
- Land
- Grossbritannien
- Protokollierter Sitz
- Alexander House Highfield Park
- Llandyrnog
- Denbighshire
- LL16 4LU
- Wales Alexander House Highfield Park, Llandyrnog, Denbighshire, LL16 4LU, Wales UK
Management
- Geschäftsführung
- HALLOWS, Graham
- MRA UK INVESTMENTS LIMITED
- Prokuristen
- -
Firmendetails
- Geschäftszweig
- ltd
- Gründungsdatum
- 05.03.2012
- Alter der Firma 2012-03-05 12 Jahre
- SIC/NACE
- 68209
Eigentumsverhältnisse
- Beneficial Owners
- -
- Mrs Joanne Adey
- Mra Uk Investments Limited
- -
- -
Landes-Besonderheiten
- Zusätzliche Statusdetails
- active
- Ehemalige Namen
- THE OLD PALACE (CHESTER) LIMITED
- Bilanzhinterlegung
- Fälligkeit: 2021-06-30
- Letzte Einreichung: 2019-06-30
- lezte Bilanzhinterlegung
- 2013-03-05
- Jahresmeldung
- Fälligkeit: 2021-04-16
- Letzte Einreichung: 2020-03-05
-
MRA REAL ESTATE LIMITED Firmenbeschreibung
- MRA REAL ESTATE LIMITED ist eine in Grossbritannien als ltd registrierte Firma mit der Register-Nr. 07975202. Ihr derzeitiger Status ist "eingetragen". Die Firma wurde 05.03.2012 registriert. MRA REAL ESTATE LIMITED hat Ihre Tätigkeit zuvor unter dem Namen THE OLD PALACE (CHESTER) LIMITED ausgeführt. Das Unternehmen ist mit dem SIC/NACE Code "68209" registriert. Das Unternehmen hat 2 Geschäftsführer Die jährliche Meldung erfolgte zuletzt am 05.03.2013.Die Firma kann schriftlich über Alexander House Highfield Park erreicht werden.
Jetzt sichern MRA REAL ESTATE LIMITED HandelsregisterauszugJahresabschlussListe der GesellschafterGesellschaftsvertragBeneficial Owners Check
Sie befinden sich hier: Mra Real Estate Limited - Alexander House Highfield Park, Llandyrnog, Denbighshire, LL16 4LU, Grossbritannien
- 2012-03-05
- 0-2
- 3-5
- 6-20
- 21-50
- 51+
- Jahre
Haben Sie gewusst? kompany stellt Ihnen amtliche & offizielle Dokumente zu MRA REAL ESTATE LIMITED aus Handelsregister und Firmenbuch im Original zur Verfügung. Das garantieren wir.
Handelsregisterauszug
Amtlicher Nachweis der Existenz des Unternehmens
Jahresabschluss
Finanzdaten zum letzten Berichtsjahr
Liste der Gesellschafter
Angaben zu den Eigentumsverhältnissen
Gesellschaftsvertrag
Gründungsdokumente
Beneficial Owners Check
Angaben über den wirtschaftlichen Eigentümer (Beneficial Owner)
Amtliche Dokumente
Amtliche Dokumente direkt vom offiziellen Handelsregister
keyboard_arrow_down 2020
-
legacy (2020-10-19) - GUARANTEE2
-
confirmation-statement-with-no-updates (2020-03-19) - CS01
-
legacy (2020-09-25) - AGREEMENT2
-
legacy (2020-10-02) - PARENT_ACC
-
accounts-with-accounts-type-audit-exemption-subsiduary (2020-10-19) - AA
keyboard_arrow_right 2019
-
resolution (2019-10-08) - RESOLUTIONS
-
accounts-with-accounts-type-unaudited-abridged (2019-04-30) - AA
-
confirmation-statement-with-updates (2019-03-13) - CS01
keyboard_arrow_right 2018
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2018-08-08) - AP01
-
legacy (2018-10-15) - CAP-SS
-
capital-statement-capital-company-with-date-currency-figure (2018-10-15) - SH19
-
legacy (2018-10-15) - SH20
-
change-account-reference-date-company-previous-extended (2018-10-22) - AA01
-
termination-secretary-company-with-name-termination-date (2018-10-22) - TM02
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2018-10-22) - TM01
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2018-10-23) - AD01
-
resolution (2018-10-15) - RESOLUTIONS
-
notification-of-a-person-with-significant-control (2018-10-23) - PSC02
-
cessation-of-a-person-with-significant-control (2018-10-23) - PSC07
-
change-of-name-notice (2018-11-05) - CONNOT
-
resolution (2018-11-05) - RESOLUTIONS
-
resolution (2018-11-13) - RESOLUTIONS
-
appoint-corporate-director-company-with-name-date (2018-10-22) - AP02
-
confirmation-statement-with-updates (2018-03-13) - CS01
-
cessation-of-a-person-with-significant-control (2018-03-13) - PSC07
-
notification-of-a-person-with-significant-control (2018-03-13) - PSC01
keyboard_arrow_right 2017
-
accounts-with-accounts-type-unaudited-abridged (2017-12-28) - AA
-
confirmation-statement-with-updates (2017-03-16) - CS01
keyboard_arrow_right 2016
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2016-12-23) - AA
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2016-03-16) - AR01
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2016-03-16) - TM01
keyboard_arrow_right 2015
-
capital-allotment-shares (2015-06-02) - SH01
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2015-03-06) - AR01
-
resolution (2015-06-02) - RESOLUTIONS
-
termination-secretary-company-with-name-termination-date (2015-12-14) - TM02
-
appoint-person-secretary-company-with-name-date (2015-12-14) - AP03
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2015-12-31) - AA
keyboard_arrow_right 2014
-
resolution (2014-06-16) - RESOLUTIONS
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2014-12-23) - AA
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2014-09-22) - AP01
-
appoint-person-secretary-company-with-name-date (2014-09-04) - AP03
-
appoint-person-director-company-with-name (2014-01-24) - AP01
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2014-03-10) - AR01
keyboard_arrow_right 2013
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2013-11-25) - AA
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2013-03-07) - AR01
keyboard_arrow_right 2012
-
incorporation-company (2012-03-05) - NEWINC