-
RETAIL PRINT LTD - Moorend House, Snelsins Road, Cleckheaton, West Yorkshire, Grossbritannien
Firmenprofil
- Handelsregisternummer
- 07972109
- Firmenstatus
- EINGETRAGEN
- Land
- Grossbritannien
- Protokollierter Sitz
- Moorend House
- Snelsins Road
- Cleckheaton
- West Yorkshire
- BD19 3UE Moorend House, Snelsins Road, Cleckheaton, West Yorkshire, BD19 3UE UK
Management
- Geschäftsführung
- CHANDLER, Karl Haydon
- STEEPLES, Chris
- WADDLE, Paul
Firmendetails
- Geschäftszweig
- ltd
- Gründungsdatum
- 01.03.2012
- Alter der Firma 2012-03-01 12 Jahre
- SIC/NACE
- 74100
Eigentumsverhältnisse
- Beneficial Owners
- Rsg Group Holdings Ltd
Landes-Besonderheiten
- Zusätzliche Statusdetails
- liquidation
- Ehemalige Namen
- RS DIGITAL PRINT LTD
- Bilanzhinterlegung
- Fälligkeit: 2019-09-30
- Letzte Einreichung: 2017-12-31
- Jahresmeldung
- Fälligkeit: 2019-03-15
- Letzte Einreichung: 2018-03-01
-
RETAIL PRINT LTD Firmenbeschreibung
- RETAIL PRINT LTD ist eine in Grossbritannien als ltd registrierte Firma mit der Register-Nr. 07972109. Ihr derzeitiger Status ist "eingetragen". Die Firma wurde 01.03.2012 registriert. RETAIL PRINT LTD hat Ihre Tätigkeit zuvor unter dem Namen RS DIGITAL PRINT LTD ausgeführt. Das Unternehmen ist mit dem SIC/NACE Code "74100" registriert. Das Unternehmen hat 3 Geschäftsführer Die Bilanz wurde zuletzt am 31.12.2017 hinterlegt.Die Firma kann schriftlich über Moorend House erreicht werden.
Jetzt sichern RETAIL PRINT LTD HandelsregisterauszugJahresabschlussListe der GesellschafterGesellschaftsvertragBeneficial Owners Check
Sie befinden sich hier: Retail Print Ltd - Moorend House, Snelsins Road, Cleckheaton, West Yorkshire, Grossbritannien
- 2012-03-01
- 0-2
- 3-5
- 6-20
- 21-50
- 51+
- Jahre
Haben Sie gewusst? kompany stellt Ihnen amtliche & offizielle Dokumente zu RETAIL PRINT LTD aus Handelsregister und Firmenbuch im Original zur Verfügung. Das garantieren wir.
Handelsregisterauszug
Amtlicher Nachweis der Existenz des Unternehmens
Jahresabschluss
Finanzdaten zum letzten Berichtsjahr
Liste der Gesellschafter
Angaben zu den Eigentumsverhältnissen
Gesellschaftsvertrag
Gründungsdokumente
Beneficial Owners Check
Angaben über den wirtschaftlichen Eigentümer (Beneficial Owner)
Amtliche Dokumente
Amtliche Dokumente direkt vom offiziellen Handelsregister
keyboard_arrow_down 2021
-
liquidation-voluntary-creditors-return-of-final-meeting (2021-06-09) - LIQ14
-
liquidation-voluntary-removal-of-liquidator-by-court (2021-03-24) - LIQ10
-
liquidation-voluntary-appointment-of-liquidator (2021-03-24) - 600
keyboard_arrow_right 2020
-
liquidation-voluntary-statement-of-receipts-and-payments-with-brought-down-date (2020-07-15) - LIQ03
keyboard_arrow_right 2019
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2019-02-28) - AD01
-
liquidation-voluntary-statement-of-affairs (2019-02-27) - LIQ02
-
liquidation-voluntary-appointment-of-liquidator (2019-02-27) - 600
-
resolution (2019-02-27) - RESOLUTIONS
-
mortgage-satisfy-charge-full (2019-01-08) - MR04
keyboard_arrow_right 2018
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2018-06-14) - AA
-
confirmation-statement-with-no-updates (2018-03-07) - CS01
-
change-person-director-company-with-change-date (2018-03-06) - CH01
keyboard_arrow_right 2017
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2017-04-18) - AA
-
confirmation-statement-with-updates (2017-03-03) - CS01
-
mortgage-create-with-deed-with-charge-number-charge-creation-date (2017-01-20) - MR01
keyboard_arrow_right 2016
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2016-03-23) - AR01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2016-07-28) - AA
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2016-03-21) - AP01
keyboard_arrow_right 2015
-
capital-allotment-shares (2015-12-17) - SH01
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2015-11-29) - TM01
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2015-11-29) - AP01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2015-09-04) - AA
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2015-03-06) - AR01
keyboard_arrow_right 2014
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2014-03-31) - AA
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2014-03-24) - AA
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2014-03-21) - AR01
-
mortgage-create-with-deed-with-charge-number (2014-01-30) - MR01
keyboard_arrow_right 2013
-
change-account-reference-date-company-previous-shortened (2013-11-13) - AA01
-
legacy (2013-03-28) - MG01
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2013-03-06) - AR01
keyboard_arrow_right 2012
-
incorporation-company (2012-03-01) - NEWINC
-
appoint-person-director-company-with-name (2012-04-17) - AP01
-
certificate-change-of-name-company (2012-05-01) - CERTNM