-
PREMIER BUSINESS COST SAVINGS SPECIALISTS LTD - Rossington's Business Park, West Carr Road, Retford, Nottinghamshire, Grossbritannien
Firmenprofil
- Handelsregisternummer
- 07966466
- Firmenstatus
- EINGETRAGEN
- Land
- Grossbritannien
- Protokollierter Sitz
- Rossington's Business Park
- West Carr Road
- Retford
- Nottinghamshire
- DN22 7SW
- England Rossington's Business Park, West Carr Road, Retford, Nottinghamshire, DN22 7SW, England UK
Management
- Geschäftsführung
- REDGWELL, Steven
- PERKINS, Gavin Matthew
- MCMILLAN, Carl Lloyd
- Prokuristen
- GRIFFIN, Elisa
Firmendetails
- Geschäftszweig
- ltd
- Gründungsdatum
- 27.02.2012
- Alter der Firma 2012-02-27 12 Jahre
- SIC/NACE
- 70229
Eigentumsverhältnisse
- Beneficial Owners
- Pib Group Limited
Landes-Besonderheiten
- Zusätzliche Statusdetails
- active
- Bilanzhinterlegung
- Fälligkeit: 2022-09-30
- Letzte Einreichung: 2020-12-31
- Jahresmeldung
- Fälligkeit: 2022-03-13
- Letzte Einreichung: 2021-02-27
-
PREMIER BUSINESS COST SAVINGS SPECIALISTS LTD Firmenbeschreibung
- PREMIER BUSINESS COST SAVINGS SPECIALISTS LTD ist eine in Grossbritannien als ltd registrierte Firma mit der Register-Nr. 07966466. Ihr derzeitiger Status ist "eingetragen". Die Firma wurde 27.02.2012 registriert. Das Unternehmen ist mit dem SIC/NACE Code "70229" registriert. Das Unternehmen hat 3 Geschäftsführer und 1 Prokuristen. Die Bilanz wurde zuletzt am 31.12.2020 hinterlegt.Die Firma kann schriftlich über Rossington's Business Park erreicht werden.
Jetzt sichern PREMIER BUSINESS COST SAVINGS SPECIALISTS LTD HandelsregisterauszugJahresabschlussListe der GesellschafterGesellschaftsvertragBeneficial Owners Check
Sie befinden sich hier: Premier Business Cost Savings Specialists Ltd - Rossington's Business Park, West Carr Road, Retford, Nottinghamshire, Grossbritannien
- 2012-02-27
- 0-2
- 3-5
- 6-20
- 21-50
- 51+
- Jahre
Haben Sie gewusst? kompany stellt Ihnen amtliche & offizielle Dokumente zu PREMIER BUSINESS COST SAVINGS SPECIALISTS LTD aus Handelsregister und Firmenbuch im Original zur Verfügung. Das garantieren wir.
Handelsregisterauszug
Amtlicher Nachweis der Existenz des Unternehmens
Jahresabschluss
Finanzdaten zum letzten Berichtsjahr
Liste der Gesellschafter
Angaben zu den Eigentumsverhältnissen
Gesellschaftsvertrag
Gründungsdokumente
Beneficial Owners Check
Angaben über den wirtschaftlichen Eigentümer (Beneficial Owner)
Amtliche Dokumente
Amtliche Dokumente direkt vom offiziellen Handelsregister
keyboard_arrow_down 2022
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2022-01-13) - AP01
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2022-01-13) - TM01
keyboard_arrow_right 2021
-
accounts-with-accounts-type-audit-exemption-subsiduary (2021-08-26) - AA
-
confirmation-statement-with-updates (2021-03-29) - CS01
-
legacy (2021-08-26) - PARENT_ACC
-
legacy (2021-08-26) - AGREEMENT2
-
change-to-a-person-with-significant-control (2021-03-31) - PSC05
-
legacy (2021-08-26) - GUARANTEE2
keyboard_arrow_right 2020
-
legacy (2020-09-30) - PARENT_ACC
-
legacy (2020-09-30) - AGREEMENT2
-
legacy (2020-09-30) - GUARANTEE2
-
confirmation-statement-with-updates (2020-02-27) - CS01
-
change-to-a-person-with-significant-control (2020-02-27) - PSC05
-
move-registers-to-registered-office-company-with-new-address (2020-02-27) - AD04
-
accounts-with-accounts-type-audit-exemption-subsiduary (2020-11-13) - AA
keyboard_arrow_right 2019
-
change-person-director-company-with-change-date (2019-02-27) - CH01
-
confirmation-statement-with-updates (2019-02-27) - CS01
-
legacy (2019-08-19) - GUARANTEE2
-
legacy (2019-08-19) - PARENT_ACC
-
accounts-with-accounts-type-audit-exemption-subsiduary (2019-08-19) - AA
-
legacy (2019-08-19) - AGREEMENT2
keyboard_arrow_right 2018
-
accounts-with-accounts-type-audit-exemption-subsiduary (2018-10-29) - AA
-
legacy (2018-10-29) - PARENT_ACC
-
legacy (2018-10-29) - GUARANTEE2
-
legacy (2018-10-29) - AGREEMENT2
-
legacy (2018-10-15) - GUARANTEE2
-
legacy (2018-10-15) - PARENT_ACC
-
confirmation-statement-with-updates (2018-04-24) - CS01
keyboard_arrow_right 2017
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2017-11-16) - AA
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2017-09-20) - TM01
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2017-08-10) - AD01
-
change-person-director-company-with-change-date (2017-03-28) - CH01
-
confirmation-statement-with-updates (2017-04-04) - CS01
keyboard_arrow_right 2016
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2016-04-26) - TM01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2016-09-15) - AA
-
change-person-director-company-with-change-date (2016-03-30) - CH01
-
move-registers-to-sail-company-with-new-address (2016-03-31) - AD03
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2016-03-31) - AR01
-
change-sail-address-company-with-new-address (2016-03-31) - AD02
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2016-04-25) - AP01
keyboard_arrow_right 2015
-
annual-return-company-with-made-up-date (2015-03-23) - AR01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2015-05-20) - AA
keyboard_arrow_right 2014
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2014-05-21) - AA
-
annual-return-company-with-made-up-date (2014-03-12) - AR01
keyboard_arrow_right 2013
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2013-09-25) - AA
-
change-account-reference-date-company-previous-shortened (2013-04-09) - AA01
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2013-03-27) - AR01
keyboard_arrow_right 2012
-
incorporation-company (2012-02-27) - NEWINC