-
NORTH PICKENHAM ENERGY LIMITED - 7th Floor, Wellington House, 125 - 130 Strand, London, WC2R 0AP, Grossbritannien
Firmenprofil
- Handelsregisternummer
- 07964532
- Firmenstatus
- EINGETRAGEN
- Land
- Grossbritannien
- Protokollierter Sitz
- 7th Floor, Wellington House
- 125 - 130 Strand
- London
- WC2R 0AP
- England 7th Floor, Wellington House, 125 - 130 Strand, London, WC2R 0AP, England UK
Management
- Geschäftsführung
- RIDLEY, Matthew
- WATSON, Sebastian Laurence Grenville
- Prokuristen
- ROBINSON, Edward
Firmendetails
- Geschäftszweig
- ltd
- Gründungsdatum
- 24.02.2012
- Alter der Firma 2012-02-24 12 Jahre
- SIC/NACE
- 64209
Eigentumsverhältnisse
- Beneficial Owners
- Ventus Vct Plc
- Ventus 2 Vct Plc
Landes-Besonderheiten
- Zusätzliche Statusdetails
- active
- Ehemalige Namen
- OVALAU INVESTMENTS 2 LIMITED
- Bilanzhinterlegung
- Fälligkeit: 2021-12-31
- Letzte Einreichung: 2020-03-31
- Jahresmeldung
- Fälligkeit: 2022-03-10
- Letzte Einreichung: 2021-02-24
-
NORTH PICKENHAM ENERGY LIMITED Firmenbeschreibung
- NORTH PICKENHAM ENERGY LIMITED ist eine in Grossbritannien als ltd registrierte Firma mit der Register-Nr. 07964532. Ihr derzeitiger Status ist "eingetragen". Die Firma wurde 24.02.2012 registriert. NORTH PICKENHAM ENERGY LIMITED hat Ihre Tätigkeit zuvor unter dem Namen OVALAU INVESTMENTS 2 LIMITED ausgeführt. Das Unternehmen ist mit dem SIC/NACE Code "64209" registriert. Das Unternehmen hat 2 Geschäftsführer und 1 Prokuristen.Die Firma kann schriftlich über 7Th Floor, Wellington House erreicht werden.
Jetzt sichern NORTH PICKENHAM ENERGY LIMITED HandelsregisterauszugJahresabschlussListe der GesellschafterGesellschaftsvertragBeneficial Owners Check
Sie befinden sich hier: North Pickenham Energy Limited - 7th Floor, Wellington House, 125 - 130 Strand, London, WC2R 0AP, Grossbritannien
- 2012-02-24
- 0-2
- 3-5
- 6-20
- 21-50
- 51+
- Jahre
Haben Sie gewusst? kompany stellt Ihnen amtliche & offizielle Dokumente zu NORTH PICKENHAM ENERGY LIMITED aus Handelsregister und Firmenbuch im Original zur Verfügung. Das garantieren wir.
Handelsregisterauszug
Amtlicher Nachweis der Existenz des Unternehmens
Jahresabschluss
Finanzdaten zum letzten Berichtsjahr
Liste der Gesellschafter
Angaben zu den Eigentumsverhältnissen
Gesellschaftsvertrag
Gründungsdokumente
Beneficial Owners Check
Angaben über den wirtschaftlichen Eigentümer (Beneficial Owner)
Amtliche Dokumente
Amtliche Dokumente direkt vom offiziellen Handelsregister
keyboard_arrow_down 2021
-
confirmation-statement-with-no-updates (2021-03-03) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2021-05-10) - AA
keyboard_arrow_right 2020
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2020-01-02) - AA
-
confirmation-statement-with-no-updates (2020-02-28) - CS01
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2020-12-02) - AD01
keyboard_arrow_right 2019
-
confirmation-statement-with-no-updates (2019-02-28) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2019-01-03) - AA
keyboard_arrow_right 2018
-
confirmation-statement-with-no-updates (2018-03-05) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2018-01-02) - AA
keyboard_arrow_right 2017
-
mortgage-create-with-deed-with-charge-number-charge-creation-date (2017-10-27) - MR01
-
confirmation-statement-with-updates (2017-03-08) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2017-01-03) - AA
keyboard_arrow_right 2016
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2016-11-14) - TM01
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2016-11-14) - AP01
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2016-03-22) - AR01
-
capital-statement-capital-company-with-date-currency-figure (2016-02-03) - SH19
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2016-01-09) - AA
keyboard_arrow_right 2015
-
resolution (2015-10-14) - RESOLUTIONS
-
legacy (2015-10-14) - SH20
-
legacy (2015-10-14) - CAP-SS
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2015-09-02) - TM01
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2015-09-02) - AP01
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2015-03-18) - AR01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2015-01-03) - AA
keyboard_arrow_right 2014
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2014-03-20) - AR01
keyboard_arrow_right 2013
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2013-11-19) - AA
-
change-account-reference-date-company-previous-extended (2013-10-31) - AA01
-
mortgage-create-with-deed-with-charge-number (2013-08-08) - MR01
-
certificate-change-of-name-company (2013-05-02) - CERTNM
-
appoint-person-secretary-company-with-name (2013-04-30) - AP03
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2013-04-10) - AR01
-
capital-allotment-shares (2013-03-18) - SH01
-
termination-secretary-company-with-name (2013-02-28) - TM02
keyboard_arrow_right 2012
-
appoint-corporate-secretary-company-with-name (2012-05-01) - AP04
-
incorporation-company (2012-02-24) - NEWINC
-
resolution (2012-03-14) - RESOLUTIONS