-
PATRICK PROPERTIES NORTHAMPTON LIMITED - Hamilton House, Church Street, Altrincham, WA14 4DR, Grossbritannien
Firmenprofil
- Handelsregisternummer
- 07955176
- Firmenstatus
- EINGETRAGEN
- Land
- Grossbritannien
- Protokollierter Sitz
- Hamilton House
- Church Street
- Altrincham
- WA14 4DR
- England Hamilton House, Church Street, Altrincham, WA14 4DR, England UK
Management
- Geschäftsführung
- HALPIN, Timothy John
Firmendetails
- Geschäftszweig
- ltd
- Gründungsdatum
- 20.02.2012
- Alter der Firma 2012-02-20 12 Jahre
- SIC/NACE
- 68209
Eigentumsverhältnisse
- Beneficial Owners
- Patrick Properties Group Limited
Landes-Besonderheiten
- Zusätzliche Statusdetails
- active
- Bilanzhinterlegung
- Fälligkeit: 2023-12-20
- Letzte Einreichung: 2021-09-30
- lezte Bilanzhinterlegung
- 2013-02-20
- Jahresmeldung
- Fälligkeit: 2025-03-06
- Letzte Einreichung: 2024-02-20
-
PATRICK PROPERTIES NORTHAMPTON LIMITED Firmenbeschreibung
- PATRICK PROPERTIES NORTHAMPTON LIMITED ist eine in Grossbritannien als ltd registrierte Firma mit der Register-Nr. 07955176. Ihr derzeitiger Status ist "eingetragen". Die Firma wurde 20.02.2012 registriert. Das Unternehmen ist mit dem SIC/NACE Code "68209" registriert. Das Unternehmen hat 1 Geschäftsführer Die jährliche Meldung erfolgte zuletzt am 20.02.2013.Die Firma kann schriftlich über Hamilton House erreicht werden.
Jetzt sichern PATRICK PROPERTIES NORTHAMPTON LIMITED HandelsregisterauszugJahresabschlussListe der GesellschafterGesellschaftsvertragBeneficial Owners Check
Sie befinden sich hier: Patrick Properties Northampton Limited - Hamilton House, Church Street, Altrincham, WA14 4DR, Grossbritannien
- 2012-02-20
- 0-2
- 3-5
- 6-20
- 21-50
- 51+
- Jahre
Haben Sie gewusst? kompany stellt Ihnen amtliche & offizielle Dokumente zu PATRICK PROPERTIES NORTHAMPTON LIMITED aus Handelsregister und Firmenbuch im Original zur Verfügung. Das garantieren wir.
Handelsregisterauszug
Amtlicher Nachweis der Existenz des Unternehmens
Jahresabschluss
Finanzdaten zum letzten Berichtsjahr
Liste der Gesellschafter
Angaben zu den Eigentumsverhältnissen
Gesellschaftsvertrag
Gründungsdokumente
Beneficial Owners Check
Angaben über den wirtschaftlichen Eigentümer (Beneficial Owner)
Amtliche Dokumente
Amtliche Dokumente direkt vom offiziellen Handelsregister
keyboard_arrow_down 2024
-
gazette-filings-brought-up-to-date (2024-02-24) - DISS40
-
confirmation-statement-with-no-updates (2024-02-23) - CS01
-
gazette-notice-compulsory (2024-02-20) - GAZ1
keyboard_arrow_right 2023
-
change-account-reference-date-company-previous-shortened (2023-09-20) - AA01
-
gazette-filings-brought-up-to-date (2023-01-04) - DISS40
-
accounts-with-accounts-type-small (2023-01-10) - AA
-
confirmation-statement-with-no-updates (2023-02-28) - CS01
-
change-account-reference-date-company-previous-shortened (2023-06-22) - AA01
keyboard_arrow_right 2022
-
confirmation-statement-with-no-updates (2022-02-25) - CS01
-
dissolved-compulsory-strike-off-suspended (2022-12-30) - DISS16(SOAS)
-
gazette-notice-compulsory (2022-11-29) - GAZ1
-
change-account-reference-date-company-previous-shortened (2022-06-28) - AA01
keyboard_arrow_right 2021
-
accounts-with-accounts-type-small (2021-10-21) - AA
-
confirmation-statement-with-no-updates (2021-03-02) - CS01
-
change-account-reference-date-company-current-shortened (2021-09-29) - AA01
keyboard_arrow_right 2020
-
mortgage-satisfy-charge-full (2020-06-18) - MR04
-
accounts-with-accounts-type-small (2020-05-19) - AA
-
confirmation-statement-with-no-updates (2020-03-02) - CS01
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2020-11-16) - TM01
-
mortgage-create-with-deed-with-charge-number-charge-creation-date (2020-05-12) - MR01
keyboard_arrow_right 2019
-
change-account-reference-date-company-previous-shortened (2019-06-26) - AA01
-
confirmation-statement-with-no-updates (2019-03-01) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-small (2019-09-26) - AA
keyboard_arrow_right 2018
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2018-06-27) - AP01
-
confirmation-statement-with-no-updates (2018-02-23) - CS01
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2018-11-19) - TM01
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2018-11-19) - AP01
-
accounts-with-accounts-type-small (2018-06-29) - AA
keyboard_arrow_right 2017
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2017-07-10) - AD01
-
accounts-with-accounts-type-small (2017-07-03) - AA
-
confirmation-statement-with-updates (2017-02-23) - CS01
keyboard_arrow_right 2016
-
accounts-with-accounts-type-full (2016-11-07) - AA
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2016-03-16) - AR01
keyboard_arrow_right 2015
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2015-10-05) - TM01
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2015-09-08) - TM01
-
accounts-with-accounts-type-full (2015-07-04) - AA
-
resolution (2015-01-12) - RESOLUTIONS
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2015-03-10) - AR01
keyboard_arrow_right 2014
-
mortgage-satisfy-charge-full (2014-12-24) - MR04
-
mortgage-create-with-deed-with-charge-number-charge-creation-date (2014-12-13) - MR01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2014-06-30) - AA
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2014-03-17) - AR01
keyboard_arrow_right 2013
-
change-account-reference-date-company-previous-shortened (2013-11-25) - AA01
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2013-03-19) - AR01
-
capital-allotment-shares (2013-03-08) - SH01
-
legacy (2013-01-24) - MG01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2013-11-20) - AA
keyboard_arrow_right 2012
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2012-06-25) - TM01
-
incorporation-company (2012-02-20) - NEWINC