-
RAINDOG FILMS LIMITED - 107 Promenade, Cheltenham, GL50 1NW, England, Grossbritannien
Firmenprofil
- Handelsregisternummer
- 07954511
- Firmenstatus
- EINGETRAGEN
- Land
- Grossbritannien
- Protokollierter Sitz
- 107 Promenade
- Cheltenham
- GL50 1NW
- England 107 Promenade, Cheltenham, GL50 1NW, England UK
Management
- Geschäftsführung
- CHETTY, Trish Deen
- DOHERTY, Ged
- FUSS, Stephen G
Firmendetails
- Geschäftszweig
- ltd
- Gründungsdatum
- 17.02.2012
- Alter der Firma 2012-02-17 12 Jahre
- SIC/NACE
- 59111
Eigentumsverhältnisse
- Beneficial Owners
- Mr Ged Doherty
- Colin Firth
- Mr Ged Doherty
- Colin Firth
Landes-Besonderheiten
- Zusätzliche Statusdetails
- active
- Bilanzhinterlegung
- Fälligkeit: 2021-09-30
- Letzte Einreichung: 2019-12-31
- lezte Bilanzhinterlegung
- 2018-02-17
- Jahresmeldung
- Fälligkeit: 2021-01-23
- Letzte Einreichung: 2020-01-09
-
RAINDOG FILMS LIMITED Firmenbeschreibung
- RAINDOG FILMS LIMITED ist eine in Grossbritannien als ltd registrierte Firma mit der Register-Nr. 07954511. Ihr derzeitiger Status ist "eingetragen". Die Firma wurde 17.02.2012 registriert. Das Unternehmen ist mit dem SIC/NACE Code "59111" registriert. Das Unternehmen hat 3 Geschäftsführer Die Bilanz wurde zuletzt am 31.12.2019 hinterlegt. Die jährliche Meldung erfolgte zuletzt am 17.02.2018.Die Firma kann schriftlich über 107 Promenade erreicht werden.
Jetzt sichern RAINDOG FILMS LIMITED HandelsregisterauszugJahresabschlussListe der GesellschafterGesellschaftsvertragBeneficial Owners Check
Sie befinden sich hier: Raindog Films Limited - 107 Promenade, Cheltenham, GL50 1NW, England, Grossbritannien
- 2012-02-17
- 0-2
- 3-5
- 6-20
- 21-50
- 51+
- Jahre
Haben Sie gewusst? kompany stellt Ihnen amtliche & offizielle Dokumente zu RAINDOG FILMS LIMITED aus Handelsregister und Firmenbuch im Original zur Verfügung. Das garantieren wir.
Handelsregisterauszug
Amtlicher Nachweis der Existenz des Unternehmens
Jahresabschluss
Finanzdaten zum letzten Berichtsjahr
Liste der Gesellschafter
Angaben zu den Eigentumsverhältnissen
Gesellschaftsvertrag
Gründungsdokumente
Beneficial Owners Check
Angaben über den wirtschaftlichen Eigentümer (Beneficial Owner)
Amtliche Dokumente
Amtliche Dokumente direkt vom offiziellen Handelsregister
keyboard_arrow_down 2020
-
capital-name-of-class-of-shares (2020-04-20) - SH08
-
confirmation-statement-with-updates (2020-01-09) - CS01
-
change-to-a-person-with-significant-control (2020-01-09) - PSC04
-
change-to-a-person-with-significant-control (2020-01-08) - PSC04
-
change-person-director-company-with-change-date (2020-01-08) - CH01
-
capital-allotment-shares (2020-02-19) - SH01
-
mortgage-satisfy-charge-full (2020-02-20) - MR04
-
resolution (2020-02-19) - RESOLUTIONS
-
resolution (2020-04-22) - RESOLUTIONS
-
memorandum-articles (2020-04-22) - MA
-
change-to-a-person-with-significant-control (2020-06-22) - PSC04
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2020-03-03) - AA
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2020-04-09) - AP01
-
capital-allotment-shares (2020-04-09) - SH01
keyboard_arrow_right 2019
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2019-11-15) - AD01
-
mortgage-satisfy-charge-full (2019-08-27) - MR04
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2019-08-27) - TM01
-
confirmation-statement-with-updates (2019-08-27) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2019-09-19) - AA
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2019-10-29) - AP01
-
capital-variation-of-rights-attached-to-shares (2019-11-26) - SH10
-
capital-allotment-shares (2019-11-26) - SH01
-
capital-name-of-class-of-shares (2019-11-26) - SH08
-
capital-alter-shares-subdivision (2019-12-10) - SH02
-
capital-allotment-shares (2019-12-17) - SH01
-
resolution (2019-12-27) - RESOLUTIONS
-
resolution (2019-11-26) - RESOLUTIONS
-
confirmation-statement-with-updates (2019-03-01) - CS01
keyboard_arrow_right 2018
-
confirmation-statement-with-no-updates (2018-03-15) - CS01
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2018-04-24) - AD01
-
accounts-with-accounts-type-unaudited-abridged (2018-09-30) - AA
keyboard_arrow_right 2017
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2017-11-27) - AA
-
confirmation-statement-with-updates (2017-03-14) - CS01
keyboard_arrow_right 2016
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2016-03-10) - AR01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2016-07-27) - AA
keyboard_arrow_right 2015
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2015-09-29) - AP01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2015-08-03) - AA
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2015-02-18) - AR01
-
change-person-director-company-with-change-date (2015-01-14) - CH01
keyboard_arrow_right 2014
-
capital-allotment-shares (2014-02-05) - SH01
-
capital-allotment-shares (2014-06-19) - SH01
-
mortgage-create-with-deed-with-charge-number (2014-06-24) - MR01
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2014-03-31) - AR01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2014-06-30) - AA
keyboard_arrow_right 2013
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address (2013-12-13) - AD01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2013-11-19) - AA
-
change-account-reference-date-company-previous-shortened (2013-11-12) - AA01
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2013-03-14) - AR01
keyboard_arrow_right 2012
-
appoint-person-director-company-with-name (2012-11-22) - AP01
-
termination-director-company-with-name (2012-11-21) - TM01
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address (2012-05-11) - AD01
-
incorporation-company (2012-02-17) - NEWINC