-
SWIMSEAL UK LIMITED - Marlbridge House, Enterprise Way, Edenbridge, Kent, Grossbritannien
Firmenprofil
- Handelsregisternummer
- 07952442
- Firmenstatus
- EINGETRAGEN
- Land
- Grossbritannien
- Protokollierter Sitz
- Marlbridge House
- Enterprise Way
- Edenbridge
- Kent
- TN8 6HF Marlbridge House, Enterprise Way, Edenbridge, Kent, TN8 6HF UK
Management
- Geschäftsführung
- MCARTHUR, Donald
- MCARTHUR, Jessica Anne
- SILBERBAUER, Robert Burchell
- CHAPMAN, Peter Michael
Firmendetails
- Geschäftszweig
- ltd
- Gründungsdatum
- 16.02.2012
- Alter der Firma 2012-02-16 12 Jahre
- SIC/NACE
- 32990
Eigentumsverhältnisse
- Beneficial Owners
- -
- Ms Jessica Anne Mcarthur
- Mr Donald Mcarthur
Landes-Besonderheiten
- Zusätzliche Statusdetails
- active
- Bilanzhinterlegung
- Fälligkeit: 2021-09-30
- Letzte Einreichung: 2019-12-31
- lezte Bilanzhinterlegung
- 2013-02-16
- Jahresmeldung
- Fälligkeit: 2021-07-18
- Letzte Einreichung: 2020-07-04
-
SWIMSEAL UK LIMITED Firmenbeschreibung
- SWIMSEAL UK LIMITED ist eine in Grossbritannien als ltd registrierte Firma mit der Register-Nr. 07952442. Ihr derzeitiger Status ist "eingetragen". Die Firma wurde 16.02.2012 registriert. Das Unternehmen ist mit dem SIC/NACE Code "32990" registriert. Das Unternehmen hat 4 Geschäftsführer Die jährliche Meldung erfolgte zuletzt am 16.02.2013.Die Firma kann schriftlich über Marlbridge House erreicht werden.
Jetzt sichern SWIMSEAL UK LIMITED HandelsregisterauszugJahresabschlussListe der GesellschafterGesellschaftsvertragBeneficial Owners Check
Sie befinden sich hier: Swimseal Uk Limited - Marlbridge House, Enterprise Way, Edenbridge, Kent, Grossbritannien
- 2012-02-16
- 0-2
- 3-5
- 6-20
- 21-50
- 51+
- Jahre
Haben Sie gewusst? kompany stellt Ihnen amtliche & offizielle Dokumente zu SWIMSEAL UK LIMITED aus Handelsregister und Firmenbuch im Original zur Verfügung. Das garantieren wir.
Handelsregisterauszug
Amtlicher Nachweis der Existenz des Unternehmens
Jahresabschluss
Finanzdaten zum letzten Berichtsjahr
Liste der Gesellschafter
Angaben zu den Eigentumsverhältnissen
Gesellschaftsvertrag
Gründungsdokumente
Beneficial Owners Check
Angaben über den wirtschaftlichen Eigentümer (Beneficial Owner)
Amtliche Dokumente
Amtliche Dokumente direkt vom offiziellen Handelsregister
keyboard_arrow_down 2021
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2021-01-27) - AP01
keyboard_arrow_right 2020
-
mortgage-satisfy-charge-full (2020-07-04) - MR04
-
confirmation-statement-with-updates (2020-06-03) - CS01
-
confirmation-statement-with-updates (2020-07-04) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2020-12-18) - AA
keyboard_arrow_right 2019
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2019-09-26) - AA
-
confirmation-statement-with-updates (2019-05-22) - CS01
keyboard_arrow_right 2018
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2018-11-21) - AP01
-
confirmation-statement-with-no-updates (2018-05-23) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2018-06-04) - AA
-
capital-allotment-shares (2018-11-27) - SH01
-
cessation-of-a-person-with-significant-control (2018-11-27) - PSC07
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2018-11-21) - TM01
-
notification-of-a-person-with-significant-control (2018-11-27) - PSC01
-
change-person-director-company-with-change-date (2018-11-27) - CH01
-
change-to-a-person-with-significant-control (2018-11-28) - PSC04
keyboard_arrow_right 2017
-
change-account-reference-date-company-previous-shortened (2017-03-27) - AA01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2017-09-25) - AA
-
confirmation-statement-with-updates (2017-06-05) - CS01
-
mortgage-create-with-deed-with-charge-number-charge-creation-date (2017-04-24) - MR01
keyboard_arrow_right 2016
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2016-12-16) - AA
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2016-06-16) - AR01
-
mortgage-create-with-deed-with-charge-number-charge-creation-date (2016-03-22) - MR01
keyboard_arrow_right 2015
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2015-12-22) - AA
-
change-person-director-company-with-change-date (2015-06-16) - CH01
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2015-06-12) - AR01
-
change-person-secretary-company (2015-06-12) - CH03
-
change-person-director-company-with-change-date (2015-06-12) - CH01
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2015-06-12) - AD01
keyboard_arrow_right 2014
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2014-04-29) - AR01
-
appoint-person-director-company-with-name (2014-02-20) - AP01
-
termination-director-company-with-name (2014-03-09) - TM01
-
appoint-person-director-company-with-name (2014-03-09) - AP01
-
termination-director-company-with-name (2014-04-01) - TM01
-
appoint-person-director-company-with-name (2014-06-23) - AP01
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address (2014-05-29) - AD01
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2014-05-31) - AR01
-
capital-allotment-shares (2014-08-22) - SH01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2014-09-15) - AA
keyboard_arrow_right 2013
-
change-person-director-company-with-change-date (2013-02-27) - CH01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2013-11-14) - AA
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2013-02-27) - AR01
-
change-account-reference-date-company-previous-extended (2013-11-08) - AA01
keyboard_arrow_right 2012
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address (2012-03-27) - AD01
-
incorporation-company (2012-02-16) - NEWINC