-
DELTIC CHICAGO'S LIMITED - C/O Poppleton & Appleby The Silverworks, 67-71 Northwood Street, Birmingham, B3 1TX, Grossbritannien
Firmenprofil
- Handelsregisternummer
- 07950948
- Firmenstatus
- GELÖSCHT
- Land
- Grossbritannien
- Protokollierter Sitz
- C/O Poppleton & Appleby The Silverworks
- 67-71 Northwood Street
- Birmingham
- B3 1TX
- England C/O Poppleton & Appleby The Silverworks, 67-71 Northwood Street, Birmingham, B3 1TX, England UK
Management
- Geschäftsführung
- MARKS, Peter Jack
- MILLINGTON, Alex
Firmendetails
- Geschäftszweig
- ltd
- Gründungsdatum
- 15.02.2012
- Gelöscht am:
- 2023-11-15
- SIC/NACE
- 68209
Eigentumsverhältnisse
- Beneficial Owners
- The Deltic Group Limited
- The Executors Of The Estate Of The Late Paul John Evans
Landes-Besonderheiten
- Zusätzliche Statusdetails
- Dissolved
- Ehemalige Namen
- RANIMUL 7 LIMITED
- Bilanzhinterlegung
- Fälligkeit: 2021-05-31
- Letzte Einreichung: 2019-02-23
- Jahresmeldung
- Fälligkeit: 2022-02-17
- Letzte Einreichung: 2021-02-03
-
DELTIC CHICAGO'S LIMITED Firmenbeschreibung
- DELTIC CHICAGO'S LIMITED ist eine in Grossbritannien als ltd registrierte Firma mit der Register-Nr. 07950948. Ihr derzeitiger Status ist "gelöscht". Die Firma wurde 15.02.2012 registriert. DELTIC CHICAGO'S LIMITED hat Ihre Tätigkeit zuvor unter dem Namen RANIMUL 7 LIMITED ausgeführt. Das Unternehmen ist mit dem SIC/NACE Code "68209" registriert. Das Unternehmen hat 2 Geschäftsführer Die Bilanz wurde zuletzt am 23.02.2019 hinterlegt.Die Firma kann schriftlich über C/o Poppleton & Appleby The Silverworks erreicht werden.
Jetzt sichern DELTIC CHICAGO'S LIMITED HandelsregisterauszugJahresabschlussListe der GesellschafterGesellschaftsvertragBeneficial Owners Check
Sie befinden sich hier: Deltic Chicago's Limited - C/O Poppleton & Appleby The Silverworks, 67-71 Northwood Street, Birmingham, B3 1TX, Grossbritannien
Haben Sie gewusst? kompany stellt Ihnen amtliche & offizielle Dokumente zu DELTIC CHICAGO'S LIMITED aus Handelsregister und Firmenbuch im Original zur Verfügung. Das garantieren wir.
Handelsregisterauszug
Amtlicher Nachweis der Existenz des Unternehmens
Jahresabschluss
Finanzdaten zum letzten Berichtsjahr
Liste der Gesellschafter
Angaben zu den Eigentumsverhältnissen
Gesellschaftsvertrag
Gründungsdokumente
Beneficial Owners Check
Angaben über den wirtschaftlichen Eigentümer (Beneficial Owner)
Amtliche Dokumente
Amtliche Dokumente direkt vom offiziellen Handelsregister
keyboard_arrow_down 2023
-
gazette-dissolved-liquidation (2023-11-15) - GAZ2
-
liquidation-voluntary-creditors-return-of-final-meeting (2023-08-15) - LIQ14
keyboard_arrow_right 2022
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2022-07-01) - AD01
-
liquidation-voluntary-statement-of-affairs (2022-07-23) - LIQ02
-
liquidation-voluntary-appointment-of-liquidator (2022-07-23) - 600
-
resolution (2022-07-23) - RESOLUTIONS
keyboard_arrow_right 2021
-
dissolution-application-strike-off-company (2021-07-27) - DS01
-
change-account-reference-date-company-previous-extended (2021-01-21) - AA01
-
confirmation-statement-with-no-updates (2021-02-05) - CS01
-
gazette-notice-voluntary (2021-08-03) - GAZ1(A)
-
dissolution-voluntary-strike-off-suspended (2021-09-11) - SOAS(A)
keyboard_arrow_right 2020
-
confirmation-statement-with-no-updates (2020-02-12) - CS01
keyboard_arrow_right 2019
-
accounts-with-accounts-type-dormant (2019-11-27) - AA
-
confirmation-statement-with-no-updates (2019-02-08) - CS01
keyboard_arrow_right 2018
-
accounts-with-accounts-type-dormant (2018-11-08) - AA
-
resolution (2018-05-17) - RESOLUTIONS
-
confirmation-statement-with-no-updates (2018-02-13) - CS01
keyboard_arrow_right 2017
-
accounts-with-accounts-type-full (2017-12-05) - AA
-
notification-of-a-person-with-significant-control (2017-11-21) - PSC02
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2017-03-02) - TM01
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2017-03-02) - AP01
-
confirmation-statement-with-updates (2017-02-03) - CS01
keyboard_arrow_right 2016
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2016-12-21) - AP01
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2016-12-21) - TM01
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2016-01-06) - AD01
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2016-03-03) - AR01
-
change-person-director-company-with-change-date (2016-03-03) - CH01
-
accounts-with-accounts-type-full (2016-09-01) - AA
keyboard_arrow_right 2015
-
accounts-with-accounts-type-full (2015-10-30) - AA
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2015-03-05) - AR01
keyboard_arrow_right 2014
-
accounts-with-accounts-type-dormant (2014-09-08) - AA
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2014-03-10) - AR01
keyboard_arrow_right 2013
-
accounts-with-accounts-type-dormant (2013-09-10) - AA
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2013-02-18) - AR01
keyboard_arrow_right 2012
-
termination-director-company-with-name (2012-12-11) - TM01
-
appoint-person-director-company-with-name (2012-07-12) - AP01
-
incorporation-company (2012-02-15) - NEWINC