-
BAINES JEWITT LIMITED - Spitfire House 19 Falcon Court, Preston Farm Industrial Estate, Stockton-On-Tees, TS18 3TU, Grossbritannien
Firmenprofil
- Handelsregisternummer
- 07945093
- Firmenstatus
- EINGETRAGEN
- Land
- Grossbritannien
- Protokollierter Sitz
- Spitfire House 19 Falcon Court
- Preston Farm Industrial Estate
- Stockton-On-Tees
- TS18 3TU
- United Kingdom Spitfire House 19 Falcon Court, Preston Farm Industrial Estate, Stockton-On-Tees, TS18 3TU, United Kingdom UK
Management
- Geschäftsführung
- ADAMS, Donald Frank
- BIGLEY, Michael Robert
- COOK, Trevor
- COWLEY, Anne Louise
- LESTER, Jeremy
Firmendetails
- Geschäftszweig
- ltd
- Gründungsdatum
- 10.02.2012
- Alter der Firma 2012-02-10 12 Jahre
- SIC/NACE
- 69203
Eigentumsverhältnisse
- Beneficial Owners
- Bjfm Limited
Landes-Besonderheiten
- Zusätzliche Statusdetails
- active
- Ehemalige Namen
- BAINES JEWITT SOLUTIONS LIMITED
- Bilanzhinterlegung
- Fälligkeit: 2024-03-31
- Letzte Einreichung: 2022-06-30
- lezte Bilanzhinterlegung
- 2013-02-10
- Jahresmeldung
- Fälligkeit: 2025-02-24
- Letzte Einreichung: 2024-02-10
-
BAINES JEWITT LIMITED Firmenbeschreibung
- BAINES JEWITT LIMITED ist eine in Grossbritannien als ltd registrierte Firma mit der Register-Nr. 07945093. Ihr derzeitiger Status ist "eingetragen". Die Firma wurde 10.02.2012 registriert. BAINES JEWITT LIMITED hat Ihre Tätigkeit zuvor unter dem Namen BAINES JEWITT SOLUTIONS LIMITED ausgeführt. Das Unternehmen ist mit dem SIC/NACE Code "69203" registriert. Das Unternehmen hat 5 Geschäftsführer Die jährliche Meldung erfolgte zuletzt am 10.02.2013.Die Firma kann schriftlich über Spitfire House 19 Falcon Court erreicht werden.
Jetzt sichern BAINES JEWITT LIMITED HandelsregisterauszugJahresabschlussListe der GesellschafterGesellschaftsvertragBeneficial Owners Check
Sie befinden sich hier: Baines Jewitt Limited - Spitfire House 19 Falcon Court, Preston Farm Industrial Estate, Stockton-On-Tees, TS18 3TU, Grossbritannien
- 2012-02-10
- 0-2
- 3-5
- 6-20
- 21-50
- 51+
- Jahre
Haben Sie gewusst? kompany stellt Ihnen amtliche & offizielle Dokumente zu BAINES JEWITT LIMITED aus Handelsregister und Firmenbuch im Original zur Verfügung. Das garantieren wir.
Handelsregisterauszug
Amtlicher Nachweis der Existenz des Unternehmens
Jahresabschluss
Finanzdaten zum letzten Berichtsjahr
Liste der Gesellschafter
Angaben zu den Eigentumsverhältnissen
Gesellschaftsvertrag
Gründungsdokumente
Beneficial Owners Check
Angaben über den wirtschaftlichen Eigentümer (Beneficial Owner)
Amtliche Dokumente
Amtliche Dokumente direkt vom offiziellen Handelsregister
keyboard_arrow_down 2024
-
confirmation-statement-with-no-updates (2024-02-27) - CS01
keyboard_arrow_right 2023
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2023-05-16) - AD01
-
change-person-director-company-with-change-date (2023-05-16) - CH01
-
accounts-with-accounts-type-unaudited-abridged (2023-03-30) - AA
-
change-to-a-person-with-significant-control (2023-05-16) - PSC05
-
confirmation-statement-with-updates (2023-02-14) - CS01
-
notification-of-a-person-with-significant-control (2023-03-02) - PSC02
keyboard_arrow_right 2022
-
accounts-with-accounts-type-unaudited-abridged (2022-02-03) - AA
-
confirmation-statement-with-updates (2022-03-01) - CS01
-
resolution (2022-03-03) - RESOLUTIONS
-
withdrawal-of-a-person-with-significant-control-statement (2022-11-15) - PSC09
keyboard_arrow_right 2021
-
accounts-with-accounts-type-unaudited-abridged (2021-03-17) - AA
-
confirmation-statement-with-updates (2021-05-10) - CS01
-
capital-return-purchase-own-shares (2021-05-20) - SH03
-
capital-cancellation-shares (2021-06-16) - SH06
keyboard_arrow_right 2020
-
accounts-with-accounts-type-unaudited-abridged (2020-04-01) - AA
-
confirmation-statement-with-no-updates (2020-02-24) - CS01
keyboard_arrow_right 2019
-
accounts-with-accounts-type-unaudited-abridged (2019-03-29) - AA
-
confirmation-statement-with-no-updates (2019-02-13) - CS01
keyboard_arrow_right 2018
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2018-09-18) - TM01
-
accounts-with-accounts-type-unaudited-abridged (2018-03-22) - AA
-
confirmation-statement-with-no-updates (2018-02-13) - CS01
keyboard_arrow_right 2017
-
resolution (2017-06-30) - RESOLUTIONS
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2017-01-04) - AA
-
change-of-name-notice (2017-06-30) - CONNOT
-
confirmation-statement-with-updates (2017-02-20) - CS01
-
resolution (2017-06-07) - RESOLUTIONS
-
mortgage-create-with-deed-with-charge-number-charge-creation-date (2017-08-23) - MR01
-
change-account-reference-date-company-previous-extended (2017-12-01) - AA01
keyboard_arrow_right 2016
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2016-03-11) - AR01
keyboard_arrow_right 2015
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2015-01-12) - AA
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2015-03-10) - AR01
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2015-06-12) - TM01
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2015-10-03) - AP01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2015-12-17) - AA
keyboard_arrow_right 2014
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2014-02-14) - AR01
-
change-person-director-company-with-change-date (2014-02-14) - CH01
keyboard_arrow_right 2013
-
termination-director-company-with-name (2013-06-03) - TM01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2013-11-11) - AA
-
change-account-reference-date-company-previous-extended (2013-08-13) - AA01
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2013-02-15) - AR01
keyboard_arrow_right 2012
-
incorporation-company (2012-02-10) - NEWINC
-
termination-director-company-with-name (2012-02-28) - TM01
-
capital-allotment-shares (2012-02-28) - SH01
-
appoint-person-director-company-with-name (2012-02-28) - AP01