-
ALMA VALE ROAD LIMITED - 1580 Parkway Solent Business Park, Whiteley, Fareham, Hampshire, PO15 7AG, Grossbritannien
Firmenprofil
- Handelsregisternummer
- 07943948
- Firmenstatus
- EINGETRAGEN
- Land
- Grossbritannien
- Protokollierter Sitz
- 1580 Parkway Solent Business Park
- Whiteley, Fareham
- Hampshire
- PO15 7AG 1580 Parkway Solent Business Park, Whiteley, Fareham, Hampshire, PO15 7AG UK
Management
- Geschäftsführung
- CLAMP, Iain James
- Prokuristen
- ROGERS, Victoria Frances, Mrs.
Firmendetails
- Geschäftszweig
- ltd
- Gründungsdatum
- 09.02.2012
- Alter der Firma 2012-02-09 12 Jahre
- SIC/NACE
- 41100
Landes-Besonderheiten
- Zusätzliche Statusdetails
- Liquidation
- Bilanzhinterlegung
- Fälligkeit: 2016-11-30
- Letzte Einreichung: 2015-02-28
- lezte Bilanzhinterlegung
- 2013-02-09
- Jahresmeldung
- Fälligkeit: 2017-02-23
- Letzte Einreichung:
-
ALMA VALE ROAD LIMITED Firmenbeschreibung
- ALMA VALE ROAD LIMITED ist eine in Grossbritannien als ltd registrierte Firma mit der Register-Nr. 07943948. Ihr derzeitiger Status ist "eingetragen". Die Firma wurde 09.02.2012 registriert. Das Unternehmen ist mit dem SIC/NACE Code "41100" registriert. Das Unternehmen hat 1 Geschäftsführer und 1 Prokuristen. Die jährliche Meldung erfolgte zuletzt am 09.02.2013.Die Firma kann schriftlich über 1580 Parkway Solent Business Park erreicht werden.
Jetzt sichern ALMA VALE ROAD LIMITED HandelsregisterauszugJahresabschlussListe der GesellschafterGesellschaftsvertragBeneficial Owners Check
Sie befinden sich hier: Alma Vale Road Limited - 1580 Parkway Solent Business Park, Whiteley, Fareham, Hampshire, PO15 7AG, Grossbritannien
- 2012-02-09
- 0-2
- 3-5
- 6-20
- 21-50
- 51+
- Jahre
Haben Sie gewusst? kompany stellt Ihnen amtliche & offizielle Dokumente zu ALMA VALE ROAD LIMITED aus Handelsregister und Firmenbuch im Original zur Verfügung. Das garantieren wir.
Handelsregisterauszug
Amtlicher Nachweis der Existenz des Unternehmens
Jahresabschluss
Finanzdaten zum letzten Berichtsjahr
Liste der Gesellschafter
Angaben zu den Eigentumsverhältnissen
Gesellschaftsvertrag
Gründungsdokumente
Beneficial Owners Check
Angaben über den wirtschaftlichen Eigentümer (Beneficial Owner)
Amtliche Dokumente
Amtliche Dokumente direkt vom offiziellen Handelsregister
keyboard_arrow_down 2024
-
liquidation-voluntary-statement-of-receipts-and-payments-with-brought-down-date (2024-05-04) - LIQ03
keyboard_arrow_right 2023
-
liquidation-voluntary-statement-of-receipts-and-payments-with-brought-down-date (2023-05-17) - LIQ03
keyboard_arrow_right 2022
-
liquidation-voluntary-statement-of-receipts-and-payments-with-brought-down-date (2022-05-03) - LIQ03
keyboard_arrow_right 2021
-
liquidation-voluntary-statement-of-receipts-and-payments-with-brought-down-date (2021-05-17) - LIQ03
keyboard_arrow_right 2020
-
liquidation-voluntary-statement-of-receipts-and-payments-with-brought-down-date (2020-05-20) - LIQ03
keyboard_arrow_right 2019
-
liquidation-voluntary-statement-of-receipts-and-payments-with-brought-down-date (2019-05-22) - LIQ03
keyboard_arrow_right 2018
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2018-08-13) - AD01
-
liquidation-voluntary-statement-of-receipts-and-payments-with-brought-down-date (2018-05-23) - LIQ03
keyboard_arrow_right 2017
-
liquidation-voluntary-statement-of-receipts-and-payments-with-brought-down-date (2017-04-06) - 4.68
keyboard_arrow_right 2016
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2016-04-04) - AD01
-
liquidation-voluntary-appointment-of-liquidator (2016-04-01) - 600
-
resolution (2016-04-01) - RESOLUTIONS
-
liquidation-voluntary-declaration-of-solvency (2016-04-01) - 4.70
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2016-03-21) - AP01
-
mortgage-satisfy-charge-full (2016-03-10) - MR04
keyboard_arrow_right 2015
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2015-02-19) - AR01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2015-12-06) - AA
-
accounts-amended-with-accounts-type-total-exemption-small (2015-05-14) - AAMD
keyboard_arrow_right 2014
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2014-02-18) - AR01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2014-12-02) - AA
keyboard_arrow_right 2013
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2013-11-18) - AA
-
mortgage-create-with-deed-with-charge-number (2013-10-24) - MR01
-
appoint-person-director-company-with-name (2013-08-16) - AP01
-
termination-director-company-with-name (2013-08-16) - TM01
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2013-03-13) - AR01
-
change-person-director-company-with-change-date (2013-03-13) - CH01
-
change-person-secretary-company-with-change-date (2013-03-13) - CH03
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address (2013-02-05) - AD01
keyboard_arrow_right 2012
-
termination-director-company-with-name (2012-05-21) - TM01
-
incorporation-company (2012-02-09) - NEWINC
-
appoint-person-director-company-with-name (2012-05-10) - AP01