-
METAL WIZARDS LIMITED - Unit 11-, 12 Riverside Industrial Estate, Power Station Road, Rugeley, Grossbritannien
Firmenprofil
- Handelsregisternummer
- 07935844
- Firmenstatus
- EINGETRAGEN
- Land
- Grossbritannien
- Protokollierter Sitz
- Unit 11-
- 12 Riverside Industrial Estate
- Power Station Road
- Rugeley
- Staffordshire
- WS15 2YR Unit 11-, 12 Riverside Industrial Estate, Power Station Road, Rugeley, Staffordshire, WS15 2YR UK
Management
- Geschäftsführung
- GRANT, Maureen
- HARLOW, Stephen
- Prokuristen
- GRANT, Maureen
Firmendetails
- Geschäftszweig
- ltd
- Gründungsdatum
- 03.02.2012
- Alter der Firma 2012-02-03 12 Jahre
- SIC/NACE
- 25990
Eigentumsverhältnisse
- Beneficial Owners
- -
- Joanna Harlow
Landes-Besonderheiten
- Zusätzliche Statusdetails
- Active
- Ehemalige Namen
- VISEOVIEW LIMITED
- Bilanzhinterlegung
- Fälligkeit: 2024-05-27
- Letzte Einreichung: 2022-08-27
- lezte Bilanzhinterlegung
- 2013-02-03
- Jahresmeldung
- Fälligkeit: 2024-02-17
- Letzte Einreichung: 2023-02-03
-
METAL WIZARDS LIMITED Firmenbeschreibung
- METAL WIZARDS LIMITED ist eine in Grossbritannien als ltd registrierte Firma mit der Register-Nr. 07935844. Ihr derzeitiger Status ist "eingetragen". Die Firma wurde 03.02.2012 registriert. METAL WIZARDS LIMITED hat Ihre Tätigkeit zuvor unter dem Namen VISEOVIEW LIMITED ausgeführt. Das Unternehmen ist mit dem SIC/NACE Code "25990" registriert. Das Unternehmen hat 2 Geschäftsführer und 1 Prokuristen. Die jährliche Meldung erfolgte zuletzt am 03.02.2013.Die Firma kann schriftlich über Unit 11- erreicht werden.
Jetzt sichern METAL WIZARDS LIMITED HandelsregisterauszugJahresabschlussListe der GesellschafterGesellschaftsvertragBeneficial Owners Check
Sie befinden sich hier: Metal Wizards Limited - Unit 11-, 12 Riverside Industrial Estate, Power Station Road, Rugeley, Grossbritannien
- 2012-02-03
- 0-2
- 3-5
- 6-20
- 21-50
- 51+
- Jahre
Haben Sie gewusst? kompany stellt Ihnen amtliche & offizielle Dokumente zu METAL WIZARDS LIMITED aus Handelsregister und Firmenbuch im Original zur Verfügung. Das garantieren wir.
Handelsregisterauszug
Amtlicher Nachweis der Existenz des Unternehmens
Jahresabschluss
Finanzdaten zum letzten Berichtsjahr
Liste der Gesellschafter
Angaben zu den Eigentumsverhältnissen
Gesellschaftsvertrag
Gründungsdokumente
Beneficial Owners Check
Angaben über den wirtschaftlichen Eigentümer (Beneficial Owner)
Amtliche Dokumente
Amtliche Dokumente direkt vom offiziellen Handelsregister
keyboard_arrow_down 2023
-
confirmation-statement-with-no-updates (2023-03-09) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-unaudited-abridged (2023-06-22) - AA
keyboard_arrow_right 2022
-
accounts-with-accounts-type-unaudited-abridged (2022-08-10) - AA
-
confirmation-statement-with-no-updates (2022-03-08) - CS01
keyboard_arrow_right 2021
-
confirmation-statement-with-no-updates (2021-04-07) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2021-08-26) - AA
keyboard_arrow_right 2020
-
accounts-with-accounts-type-unaudited-abridged (2020-09-02) - AA
-
confirmation-statement-with-no-updates (2020-02-16) - CS01
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2020-01-25) - TM01
keyboard_arrow_right 2019
-
change-person-director-company-with-change-date (2019-07-12) - CH01
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2019-12-03) - AP01
-
change-account-reference-date-company-previous-extended (2019-10-31) - AA01
-
mortgage-satisfy-charge-full (2019-07-16) - MR04
-
appoint-person-secretary-company-with-name-date (2019-07-12) - AP03
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2019-07-12) - AP01
-
confirmation-statement-with-no-updates (2019-02-05) - CS01
keyboard_arrow_right 2018
-
capital-allotment-shares (2018-02-16) - SH01
-
notification-of-a-person-with-significant-control (2018-02-16) - PSC03
-
cessation-of-a-person-with-significant-control (2018-02-16) - PSC07
-
accounts-with-accounts-type-micro-entity (2018-12-31) - AA
-
confirmation-statement-with-updates (2018-02-16) - CS01
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2018-02-13) - AP01
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2018-02-13) - TM01
keyboard_arrow_right 2017
-
accounts-with-accounts-type-unaudited-abridged (2017-11-22) - AA
-
resolution (2017-11-21) - RESOLUTIONS
-
change-of-name-notice (2017-11-21) - CONNOT
-
mortgage-create-with-deed-with-charge-number-charge-creation-date (2017-09-27) - MR01
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2017-09-21) - AD01
-
confirmation-statement-with-updates (2017-02-17) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2017-01-12) - AA
keyboard_arrow_right 2016
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2016-01-18) - AA
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2016-01-25) - AD01
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2016-03-23) - AR01
keyboard_arrow_right 2015
-
termination-secretary-company-with-name-termination-date (2015-10-08) - TM02
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2015-03-03) - AR01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2015-01-29) - AA
keyboard_arrow_right 2014
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2014-02-12) - AR01
keyboard_arrow_right 2013
-
accounts-with-accounts-type-dormant (2013-10-29) - AA
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2013-02-04) - AR01
keyboard_arrow_right 2012
-
incorporation-company (2012-02-03) - NEWINC