-
PRODICUS LEGAL LIMITED - 76 Wellington Street, Leeds, LS1 2AY, England, Grossbritannien
Firmenprofil
- Handelsregisternummer
- 07931947
- Firmenstatus
- EINGETRAGEN
- Land
- Grossbritannien
- Protokollierter Sitz
- 76 Wellington Street
- Leeds
- LS1 2AY
- England 76 Wellington Street, Leeds, LS1 2AY, England UK
Management
- Geschäftsführung
- SWEENEY, Martin Nicholas
- WOOD, Peter James
- Prokuristen
- WOOD, Peter James
Firmendetails
- Geschäftszweig
- ltd
- Gründungsdatum
- 01.02.2012
- Alter der Firma 2012-02-01 12 Jahre
- SIC/NACE
- 69102
Eigentumsverhältnisse
- Beneficial Owners
- -
- -
- Schofield Sweeney Llp
- -
Landes-Besonderheiten
- Zusätzliche Statusdetails
- active
- Ehemalige Namen
- JAGUAR LEGAL LIMITED
- Bilanzhinterlegung
- Fälligkeit: 2022-05-31
- Letzte Einreichung: 2020-08-31
- Jahresmeldung
- Fälligkeit: 2022-02-15
- Letzte Einreichung: 2021-02-01
-
PRODICUS LEGAL LIMITED Firmenbeschreibung
- PRODICUS LEGAL LIMITED ist eine in Grossbritannien als ltd registrierte Firma mit der Register-Nr. 07931947. Ihr derzeitiger Status ist "eingetragen". Die Firma wurde 01.02.2012 registriert. PRODICUS LEGAL LIMITED hat Ihre Tätigkeit zuvor unter dem Namen JAGUAR LEGAL LIMITED ausgeführt. Das Unternehmen ist mit dem SIC/NACE Code "69102" registriert. Das Unternehmen hat 2 Geschäftsführer und 1 Prokuristen. Die Bilanz wurde zuletzt am 31.08.2020 hinterlegt.Die Firma kann schriftlich über 76 Wellington Street erreicht werden.
Jetzt sichern PRODICUS LEGAL LIMITED HandelsregisterauszugJahresabschlussListe der GesellschafterGesellschaftsvertragBeneficial Owners Check
Sie befinden sich hier: Prodicus Legal Limited - 76 Wellington Street, Leeds, LS1 2AY, England, Grossbritannien
- 2012-02-01
- 0-2
- 3-5
- 6-20
- 21-50
- 51+
- Jahre
Haben Sie gewusst? kompany stellt Ihnen amtliche & offizielle Dokumente zu PRODICUS LEGAL LIMITED aus Handelsregister und Firmenbuch im Original zur Verfügung. Das garantieren wir.
Handelsregisterauszug
Amtlicher Nachweis der Existenz des Unternehmens
Jahresabschluss
Finanzdaten zum letzten Berichtsjahr
Liste der Gesellschafter
Angaben zu den Eigentumsverhältnissen
Gesellschaftsvertrag
Gründungsdokumente
Beneficial Owners Check
Angaben über den wirtschaftlichen Eigentümer (Beneficial Owner)
Amtliche Dokumente
Amtliche Dokumente direkt vom offiziellen Handelsregister
keyboard_arrow_down 2021
-
confirmation-statement-with-no-updates (2021-04-23) - CS01
-
cessation-of-a-person-with-significant-control (2021-04-22) - PSC07
-
notification-of-a-person-with-significant-control (2021-04-22) - PSC02
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2021-04-22) - AP01
keyboard_arrow_right 2020
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2020-12-21) - AA
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2020-12-07) - TM01
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2020-12-07) - AD01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2020-04-03) - AA
-
confirmation-statement-with-no-updates (2020-03-06) - CS01
-
notification-of-a-person-with-significant-control (2020-03-05) - PSC01
keyboard_arrow_right 2019
-
confirmation-statement-with-no-updates (2019-03-06) - CS01
keyboard_arrow_right 2018
-
confirmation-statement-with-updates (2018-02-08) - CS01
-
notification-of-a-person-with-significant-control (2018-02-08) - PSC01
-
cessation-of-a-person-with-significant-control (2018-02-08) - PSC07
-
change-account-reference-date-company-current-extended (2018-11-22) - AA01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2018-11-19) - AA
keyboard_arrow_right 2017
-
termination-secretary-company-with-name-termination-date (2017-02-23) - TM02
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2017-11-07) - AA
-
mortgage-create-with-deed-with-charge-number-charge-creation-date (2017-08-10) - MR01
-
appoint-person-secretary-company-with-name-date (2017-02-24) - AP03
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2017-02-23) - TM01
-
confirmation-statement-with-updates (2017-02-22) - CS01
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2017-02-23) - AP01
keyboard_arrow_right 2016
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2016-10-20) - AA
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2016-09-14) - AD01
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2016-02-11) - AR01
keyboard_arrow_right 2015
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2015-10-17) - AA
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2015-02-11) - AR01
keyboard_arrow_right 2014
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2014-12-03) - AA
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2014-03-04) - AR01
keyboard_arrow_right 2013
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2013-02-06) - AR01
-
capital-alter-shares-subdivision (2013-10-09) - SH02
-
resolution (2013-10-09) - RESOLUTIONS
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2013-10-14) - AA
-
appoint-person-director-company-with-name (2013-12-16) - AP01
-
capital-allotment-shares (2013-10-17) - SH01
keyboard_arrow_right 2012
-
certificate-change-of-name-company (2012-06-19) - CERTNM
-
change-of-name-notice (2012-06-19) - CONNOT
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address (2012-04-25) - AD01
-
certificate-change-of-name-company (2012-04-24) - CERTNM
-
change-of-name-notice (2012-04-24) - CONNOT
-
incorporation-company (2012-02-01) - NEWINC