-
LASER VV OPERATIONS LIMITED - 17, Dominion Street, London, EC2M 2EF, Grossbritannien
Firmenprofil
- Handelsregisternummer
- 07917226
- Firmenstatus
- GELÖSCHT
- Land
- Grossbritannien
- Protokollierter Sitz
- 17
- Dominion Street
- London
- EC2M 2EF 17, Dominion Street, London, EC2M 2EF UK
Management
- Geschäftsführung
- MINTER, Dean
- MORAR, Neal
- Prokuristen
- MORAR, Neal
Firmendetails
- Geschäftszweig
- ltd
- Gründungsdatum
- 20.01.2012
- Gelöscht am:
- 2020-12-14
- SIC/NACE
- 68209
Landes-Besonderheiten
- Zusätzliche Statusdetails
- dissolved
- Ehemalige Namen
- MREF II VV OPERATIONS LIMITED
- Bilanzhinterlegung
- Fälligkeit: 2017-09-30
- Letzte Einreichung: 2015-12-31
- lezte Bilanzhinterlegung
- 2013-01-20
- Jahresmeldung
- Fälligkeit: 2019-02-03
- Letzte Einreichung: 2018-01-20
-
LASER VV OPERATIONS LIMITED Firmenbeschreibung
- LASER VV OPERATIONS LIMITED ist eine in Grossbritannien als ltd registrierte Firma mit der Register-Nr. 07917226. Ihr derzeitiger Status ist "gelöscht". Die Firma wurde 20.01.2012 registriert. LASER VV OPERATIONS LIMITED hat Ihre Tätigkeit zuvor unter dem Namen MREF II VV OPERATIONS LIMITED ausgeführt. Das Unternehmen ist mit dem SIC/NACE Code "68209" registriert. Das Unternehmen hat 2 Geschäftsführer und 1 Prokuristen. Die Bilanz wurde zuletzt am 31.12.2015 hinterlegt. Die jährliche Meldung erfolgte zuletzt am 20.01.2013.Die Firma kann schriftlich über 17 erreicht werden.
Jetzt sichern LASER VV OPERATIONS LIMITED HandelsregisterauszugJahresabschlussListe der GesellschafterGesellschaftsvertragBeneficial Owners Check
Sie befinden sich hier: Laser Vv Operations Limited - 17, Dominion Street, London, EC2M 2EF, Grossbritannien
Haben Sie gewusst? kompany stellt Ihnen amtliche & offizielle Dokumente zu LASER VV OPERATIONS LIMITED aus Handelsregister und Firmenbuch im Original zur Verfügung. Das garantieren wir.
Handelsregisterauszug
Amtlicher Nachweis der Existenz des Unternehmens
Jahresabschluss
Finanzdaten zum letzten Berichtsjahr
Liste der Gesellschafter
Angaben zu den Eigentumsverhältnissen
Gesellschaftsvertrag
Gründungsdokumente
Beneficial Owners Check
Angaben über den wirtschaftlichen Eigentümer (Beneficial Owner)
Amtliche Dokumente
Amtliche Dokumente direkt vom offiziellen Handelsregister
keyboard_arrow_down 2020
-
liquidation-voluntary-statement-of-receipts-and-payments-with-brought-down-date (2020-02-25) - LIQ03
keyboard_arrow_right 2019
-
resolution (2019-01-19) - RESOLUTIONS
-
liquidation-voluntary-declaration-of-solvency (2019-01-19) - LIQ01
-
liquidation-voluntary-appointment-of-liquidator (2019-01-19) - 600
keyboard_arrow_right 2018
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2018-12-19) - AP01
-
mortgage-satisfy-charge-full (2018-03-05) - MR04
-
confirmation-statement-with-updates (2018-02-05) - CS01
-
dissolved-compulsory-strike-off-suspended (2018-07-11) - DISS16(SOAS)
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2018-12-19) - TM01
-
gazette-notice-compulsory (2018-06-19) - GAZ1
keyboard_arrow_right 2017
-
gazette-filings-brought-up-to-date (2017-12-09) - DISS40
-
confirmation-statement-with-updates (2017-01-20) - CS01
-
gazette-notice-compulsory (2017-12-05) - GAZ1
keyboard_arrow_right 2016
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2016-10-12) - AA
-
move-registers-to-sail-company-with-new-address (2016-02-12) - AD03
-
change-sail-address-company-with-new-address (2016-02-12) - AD02
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2016-02-01) - AR01
keyboard_arrow_right 2015
-
resolution (2015-08-13) - RESOLUTIONS
-
certificate-change-of-name-company (2015-08-15) - CERTNM
-
change-of-name-notice (2015-08-15) - CONNOT
-
accounts-with-accounts-type-full (2015-05-14) - AA
-
appoint-person-secretary-company-with-name-date (2015-05-06) - AP03
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2015-05-06) - AP01
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2015-05-06) - TM01
-
resolution (2015-04-10) - RESOLUTIONS
-
mortgage-create-with-deed-with-charge-number-charge-creation-date (2015-03-18) - MR01
-
mortgage-create-with-deed-with-charge-number-charge-creation-date (2015-02-20) - MR01
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2015-02-06) - AR01
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2015-05-06) - AD01
keyboard_arrow_right 2014
-
termination-director-company-with-name (2014-02-18) - TM01
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2014-02-28) - AR01
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2014-11-14) - AP01
-
accounts-with-accounts-type-full (2014-09-09) - AA
keyboard_arrow_right 2013
-
accounts-with-accounts-type-full (2013-10-07) - AA
-
appoint-person-director-company-with-name (2013-03-01) - AP01
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2013-02-15) - AR01
keyboard_arrow_right 2012
-
termination-secretary-company-with-name (2012-09-19) - TM02
-
legacy (2012-04-21) - MG01
-
change-account-reference-date-company-current-shortened (2012-02-16) - AA01
-
incorporation-company (2012-01-20) - NEWINC