-
AVENUE VETERINARY CENTRE (MALVERN) LIMITED - The Chocolate Factory, Keynsham, Bristol, BS31 2AU, Grossbritannien
Firmenprofil
- Handelsregisternummer
- 07914417
- Firmenstatus
- EINGETRAGEN
- Land
- Grossbritannien
- Protokollierter Sitz
- The Chocolate Factory
- Keynsham
- Bristol
- BS31 2AU The Chocolate Factory, Keynsham, Bristol, BS31 2AU UK
Management
- Geschäftsführung
- CHAPMAN, Donna Louise
- GILLINGS, Mark Andrew
Firmendetails
- Geschäftszweig
- ltd
- Gründungsdatum
- 18.01.2012
- Alter der Firma 2012-01-18 12 Jahre
- SIC/NACE
- 99999
Eigentumsverhältnisse
- Beneficial Owners
- Mr Peter Creber
- -
- Independent Vetcare Limited
- -
Landes-Besonderheiten
- Zusätzliche Statusdetails
- active
- Bilanzhinterlegung
- Fälligkeit: 2021-06-30
- Letzte Einreichung: 2019-09-30
- lezte Bilanzhinterlegung
- 2013-01-18
- Jahresmeldung
- Fälligkeit: 2021-03-01
- Letzte Einreichung: 2020-01-18
-
AVENUE VETERINARY CENTRE (MALVERN) LIMITED Firmenbeschreibung
- AVENUE VETERINARY CENTRE (MALVERN) LIMITED ist eine in Grossbritannien als ltd registrierte Firma mit der Register-Nr. 07914417. Ihr derzeitiger Status ist "eingetragen". Die Firma wurde 18.01.2012 registriert. Das Unternehmen ist mit dem SIC/NACE Code "99999" registriert. Das Unternehmen hat 2 Geschäftsführer Die jährliche Meldung erfolgte zuletzt am 18.01.2013.Die Firma kann schriftlich über The Chocolate Factory erreicht werden.
Jetzt sichern AVENUE VETERINARY CENTRE (MALVERN) LIMITED HandelsregisterauszugJahresabschlussListe der GesellschafterGesellschaftsvertragBeneficial Owners Check
Sie befinden sich hier: Avenue Veterinary Centre (Malvern) Limited - The Chocolate Factory, Keynsham, Bristol, BS31 2AU, Grossbritannien
- 2012-01-18
- 0-2
- 3-5
- 6-20
- 21-50
- 51+
- Jahre
Haben Sie gewusst? kompany stellt Ihnen amtliche & offizielle Dokumente zu AVENUE VETERINARY CENTRE (MALVERN) LIMITED aus Handelsregister und Firmenbuch im Original zur Verfügung. Das garantieren wir.
Handelsregisterauszug
Amtlicher Nachweis der Existenz des Unternehmens
Jahresabschluss
Finanzdaten zum letzten Berichtsjahr
Liste der Gesellschafter
Angaben zu den Eigentumsverhältnissen
Gesellschaftsvertrag
Gründungsdokumente
Beneficial Owners Check
Angaben über den wirtschaftlichen Eigentümer (Beneficial Owner)
Amtliche Dokumente
Amtliche Dokumente direkt vom offiziellen Handelsregister
keyboard_arrow_down 2020
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2020-06-25) - AP01
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2020-01-28) - AP01
-
confirmation-statement-with-updates (2020-01-28) - CS01
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2020-03-06) - TM01
-
change-account-reference-date-company-previous-shortened (2020-03-30) - AA01
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2020-06-23) - TM01
-
legacy (2020-06-05) - GUARANTEE2
-
legacy (2020-06-17) - PARENT_ACC
-
accounts-with-accounts-type-audit-exemption-subsiduary (2020-06-17) - AA
-
legacy (2020-06-05) - AGREEMENT2
keyboard_arrow_right 2019
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2019-03-21) - TM01
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2019-10-02) - TM01
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2019-09-18) - AP01
-
change-to-a-person-with-significant-control (2019-08-22) - PSC05
-
resolution (2019-05-07) - RESOLUTIONS
-
change-account-reference-date-company-previous-shortened (2019-04-09) - AA01
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2019-03-22) - AD01
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2019-03-21) - AP01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2019-12-03) - AA
-
cessation-of-a-person-with-significant-control (2019-03-21) - PSC07
-
confirmation-statement-with-no-updates (2019-02-26) - CS01
-
notification-of-a-person-with-significant-control (2019-03-21) - PSC02
keyboard_arrow_right 2018
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2018-12-28) - AA
-
confirmation-statement-with-updates (2018-02-20) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2018-01-08) - AA
keyboard_arrow_right 2017
-
confirmation-statement-with-updates (2017-02-22) - CS01
keyboard_arrow_right 2016
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2016-01-29) - AR01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2016-01-10) - AA
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2016-11-25) - AA
keyboard_arrow_right 2015
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2015-04-08) - AP01
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2015-02-12) - AR01
keyboard_arrow_right 2014
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2014-12-19) - AA
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2014-02-03) - AR01
keyboard_arrow_right 2013
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2013-10-03) - AA
-
change-account-reference-date-company-previous-extended (2013-08-30) - AA01
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2013-02-04) - AR01
keyboard_arrow_right 2012
-
change-person-director-company-with-change-date (2012-03-28) - CH01
-
incorporation-company (2012-01-18) - NEWINC