-
DESIGN TOSCANO UK LTD - Four Fifty Partnership, 34 Boulevard, Weston-Super-Mare, Somerset, Grossbritannien
Firmenprofil
- Handelsregisternummer
- 07913773
- Firmenstatus
- EINGETRAGEN
- Land
- Grossbritannien
- Protokollierter Sitz
- Four Fifty Partnership
- 34 Boulevard
- Weston-Super-Mare
- Somerset
- BS23 1NF
- United Kingdom Four Fifty Partnership, 34 Boulevard, Weston-Super-Mare, Somerset, BS23 1NF, United Kingdom UK
Management
- Geschäftsführung
- STOPKA, Marilyn
- STOPKA, Michael Joseph
- Prokuristen
- -
Firmendetails
- Geschäftszweig
- ltd
- Gründungsdatum
- 18.01.2012
- Alter der Firma 2012-01-18 12 Jahre
- SIC/NACE
- 47910
Eigentumsverhältnisse
- Beneficial Owners
- Design Toscano Inc
Landes-Besonderheiten
- Zusätzliche Statusdetails
- active
- Bilanzhinterlegung
- Fälligkeit: 2021-09-30
- Letzte Einreichung: 2019-12-31
- lezte Bilanzhinterlegung
- 2013-04-20
- Jahresmeldung
- Fälligkeit: 2022-05-04
- Letzte Einreichung: 2021-04-20
-
DESIGN TOSCANO UK LTD Firmenbeschreibung
- DESIGN TOSCANO UK LTD ist eine in Grossbritannien als ltd registrierte Firma mit der Register-Nr. 07913773. Ihr derzeitiger Status ist "eingetragen". Die Firma wurde 18.01.2012 registriert. Das Unternehmen ist mit dem SIC/NACE Code "47910" registriert. Das Unternehmen hat 2 Geschäftsführer Die Bilanz wurde zuletzt am 31.12.2019 hinterlegt. Die jährliche Meldung erfolgte zuletzt am 20.04.2013.Die Firma kann schriftlich über Four Fifty Partnership erreicht werden.
Jetzt sichern DESIGN TOSCANO UK LTD HandelsregisterauszugJahresabschlussListe der GesellschafterGesellschaftsvertragBeneficial Owners Check
Sie befinden sich hier: Design Toscano Uk Ltd - Four Fifty Partnership, 34 Boulevard, Weston-Super-Mare, Somerset, Grossbritannien
- 2012-01-18
- 0-2
- 3-5
- 6-20
- 21-50
- 51+
- Jahre
Haben Sie gewusst? kompany stellt Ihnen amtliche & offizielle Dokumente zu DESIGN TOSCANO UK LTD aus Handelsregister und Firmenbuch im Original zur Verfügung. Das garantieren wir.
Handelsregisterauszug
Amtlicher Nachweis der Existenz des Unternehmens
Jahresabschluss
Finanzdaten zum letzten Berichtsjahr
Liste der Gesellschafter
Angaben zu den Eigentumsverhältnissen
Gesellschaftsvertrag
Gründungsdokumente
Beneficial Owners Check
Angaben über den wirtschaftlichen Eigentümer (Beneficial Owner)
Amtliche Dokumente
Amtliche Dokumente direkt vom offiziellen Handelsregister
keyboard_arrow_down 2021
-
confirmation-statement-with-updates (2021-04-21) - CS01
keyboard_arrow_right 2020
-
confirmation-statement-with-updates (2020-04-23) - CS01
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2020-04-23) - AD01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2020-01-31) - AA
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2020-11-23) - AA
keyboard_arrow_right 2019
-
confirmation-statement-with-updates (2019-05-24) - CS01
keyboard_arrow_right 2018
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2018-12-12) - TM01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2018-10-30) - AA
-
confirmation-statement-with-updates (2018-05-01) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2018-02-15) - AA
-
notification-of-a-person-with-significant-control (2018-01-08) - PSC02
keyboard_arrow_right 2017
-
gazette-filings-brought-up-to-date (2017-07-12) - DISS40
-
confirmation-statement-with-updates (2017-07-11) - CS01
-
gazette-notice-compulsory (2017-07-11) - GAZ1
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2017-07-07) - TM01
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2017-02-07) - AP01
keyboard_arrow_right 2016
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2016-09-29) - AA
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2016-05-10) - AR01
keyboard_arrow_right 2015
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2015-06-30) - AA
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2015-05-13) - AR01
-
change-person-director-company-with-change-date (2015-05-13) - CH01
-
termination-secretary-company-with-name-termination-date (2015-05-13) - TM02
keyboard_arrow_right 2014
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2014-05-20) - AA
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2014-05-08) - AR01
keyboard_arrow_right 2013
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2013-05-20) - AR01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2013-04-02) - AA
keyboard_arrow_right 2012
-
change-account-reference-date-company-current-shortened (2012-08-02) - AA01
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2012-04-24) - AR01
-
termination-director-company-with-name (2012-01-24) - TM01
-
appoint-person-director-company-with-name (2012-01-24) - AP01
-
appoint-person-secretary-company-with-name (2012-01-23) - AP03
-
incorporation-company (2012-01-18) - NEWINC