-
QUBA SOLUTIONS LIMITED - 1 Widcombe Street, Poundbury, Dorchester, Dorset, Grossbritannien
Firmenprofil
- Handelsregisternummer
- 07907578
- Firmenstatus
- EINGETRAGEN
- Land
- Grossbritannien
- Protokollierter Sitz
- 1 Widcombe Street
- Poundbury
- Dorchester
- Dorset
- DT1 3BS 1 Widcombe Street, Poundbury, Dorchester, Dorset, DT1 3BS UK
Management
- Geschäftsführung
- KING, Richard Mark
- TONKS, Paul David
- LYAS, Ashley David
Firmendetails
- Geschäftszweig
- ltd
- Gründungsdatum
- 12.01.2012
- Alter der Firma 2012-01-12 12 Jahre
- SIC/NACE
- 64992
Eigentumsverhältnisse
- Beneficial Owners
- -
- Mr Richard Mark King
- Clipper Cg Holdings Limited
- -
- Mrs Dianne Deborah Tonks
- Mrs Katie Lyas
Landes-Besonderheiten
- Zusätzliche Statusdetails
- Active
- Ehemalige Namen
- CLIPPER CIS LIMITED
- Bilanzhinterlegung
- Fälligkeit: 2025-03-31
- Letzte Einreichung: 2023-07-02
- lezte Bilanzhinterlegung
- 2013-01-12
- Jahresmeldung
- Fälligkeit: 2024-10-28
- Letzte Einreichung: 2023-10-14
-
QUBA SOLUTIONS LIMITED Firmenbeschreibung
- QUBA SOLUTIONS LIMITED ist eine in Grossbritannien als ltd registrierte Firma mit der Register-Nr. 07907578. Ihr derzeitiger Status ist "eingetragen". Die Firma wurde 12.01.2012 registriert. QUBA SOLUTIONS LIMITED hat Ihre Tätigkeit zuvor unter dem Namen CLIPPER CIS LIMITED ausgeführt. Das Unternehmen ist mit dem SIC/NACE Code "64992" registriert. Das Unternehmen hat 3 Geschäftsführer Die jährliche Meldung erfolgte zuletzt am 12.01.2013.Die Firma kann schriftlich über 1 Widcombe Street erreicht werden.
Jetzt sichern QUBA SOLUTIONS LIMITED HandelsregisterauszugJahresabschlussListe der GesellschafterGesellschaftsvertragBeneficial Owners Check
Sie befinden sich hier: Quba Solutions Limited - 1 Widcombe Street, Poundbury, Dorchester, Dorset, Grossbritannien
- 2012-01-12
- 0-2
- 3-5
- 6-20
- 21-50
- 51+
- Jahre
Haben Sie gewusst? kompany stellt Ihnen amtliche & offizielle Dokumente zu QUBA SOLUTIONS LIMITED aus Handelsregister und Firmenbuch im Original zur Verfügung. Das garantieren wir.
Handelsregisterauszug
Amtlicher Nachweis der Existenz des Unternehmens
Jahresabschluss
Finanzdaten zum letzten Berichtsjahr
Liste der Gesellschafter
Angaben zu den Eigentumsverhältnissen
Gesellschaftsvertrag
Gründungsdokumente
Beneficial Owners Check
Angaben über den wirtschaftlichen Eigentümer (Beneficial Owner)
Amtliche Dokumente
Amtliche Dokumente direkt vom offiziellen Handelsregister
keyboard_arrow_down 2024
-
accounts-with-accounts-type-full (2024-01-10) - AA
keyboard_arrow_right 2023
-
notification-of-a-person-with-significant-control (2023-07-21) - PSC01
-
change-to-a-person-with-significant-control (2023-07-19) - PSC04
-
notification-of-a-person-with-significant-control (2023-07-18) - PSC02
-
cessation-of-a-person-with-significant-control (2023-07-18) - PSC07
-
accounts-with-accounts-type-full (2023-01-06) - AA
-
confirmation-statement-with-no-updates (2023-10-16) - CS01
keyboard_arrow_right 2022
-
confirmation-statement-with-no-updates (2022-10-14) - CS01
-
mortgage-satisfy-charge-full (2022-01-04) - MR04
-
accounts-with-accounts-type-full (2022-01-31) - AA
keyboard_arrow_right 2021
-
mortgage-create-with-deed-with-charge-number-charge-creation-date (2021-12-21) - MR01
-
change-to-a-person-with-significant-control (2021-12-08) - PSC04
-
confirmation-statement-with-no-updates (2021-10-22) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-full (2021-02-16) - AA
keyboard_arrow_right 2020
-
confirmation-statement-with-no-updates (2020-10-22) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2020-02-12) - AA
keyboard_arrow_right 2019
-
confirmation-statement-with-no-updates (2019-10-18) - CS01
keyboard_arrow_right 2018
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2018-12-06) - AA
-
confirmation-statement-with-updates (2018-10-22) - CS01
-
resolution (2018-06-28) - RESOLUTIONS
-
mortgage-satisfy-charge-full (2018-06-21) - MR04
-
mortgage-create-with-deed-with-charge-number-charge-creation-date (2018-06-20) - MR01
-
capital-allotment-shares (2018-06-14) - SH01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2018-02-28) - AA
keyboard_arrow_right 2017
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2017-03-13) - AA
-
confirmation-statement-with-no-updates (2017-11-20) - CS01
keyboard_arrow_right 2016
-
mortgage-create-with-deed-with-charge-number-charge-creation-date (2016-08-23) - MR01
-
confirmation-statement-with-updates (2016-10-29) - CS01
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2016-07-21) - TM01
keyboard_arrow_right 2015
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2015-10-15) - AR01
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2015-10-14) - AP01
-
change-person-director-company-with-change-date (2015-02-20) - CH01
-
certificate-change-of-name-company (2015-06-26) - CERTNM
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2015-02-20) - AR01
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2015-10-14) - TM01
-
accounts-with-accounts-type-dormant (2015-10-14) - AA
keyboard_arrow_right 2014
-
change-person-director-company-with-change-date (2014-01-17) - CH01
-
accounts-with-accounts-type-dormant (2014-11-04) - AA
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2014-08-05) - AP01
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address (2014-06-17) - AD01
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2014-03-04) - AR01
keyboard_arrow_right 2013
-
accounts-with-accounts-type-dormant (2013-09-25) - AA
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2013-01-29) - AR01
keyboard_arrow_right 2012
-
incorporation-company (2012-01-12) - NEWINC
-
change-account-reference-date-company-current-extended (2012-03-09) - AA01